STAKIS LEISURE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTAKIS LEISURE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03146103
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STAKIS LEISURE LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich STAKIS LEISURE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Poynt
    45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von STAKIS LEISURE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EVENTDAY LIMITED15. Jan. 199615. Jan. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STAKIS LEISURE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Sept. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für STAKIS LEISURE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England am 31. Juli 2013

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 24. Juli 2013

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Sept. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Kapitalaufstellung am 23. Mai 2013

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium cancelled 16/05/2013
    RES13

    Änderung der Details des Direktors für Mr Harry Willits am 19. Feb. 2013

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 71 Queensway London W2 4QH England am 15. Feb. 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Sept. 2010

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Diane Penfold als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Harry Willits als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung von Gala Coral Properties Limited als Direktor

    2 SeitenAP02

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Sept. 2009

    5 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von STAKIS LEISURE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Sekretär
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3720332
    154706260001
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Sekretär
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Sekretär
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENNETT, Michael Daniel
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    Geschäftsführer
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    British71518290003
    BLUNT, Paul Edward
    24 Halsey Park
    London Colney
    AL2 1BH St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    24 Halsey Park
    London Colney
    AL2 1BH St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish171154410001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    DARBY, Linda Ellen
    79 Queensway
    W2 4QH London
    Geschäftsführer
    79 Queensway
    W2 4QH London
    British56628810001
    DAVEY, Johann Lesley
    71 Queensway
    W2 4QH London
    Geschäftsführer
    71 Queensway
    W2 4QH London
    British42372810002
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Geschäftsführer
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    HARLEY, Susan Boyle
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41384040001
    HAYWARD, Patrick Henry
    81 Queensway
    W2 4QY London
    Geschäftsführer
    81 Queensway
    W2 4QY London
    British52032550002
    KELLY, John Michael
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    Geschäftsführer
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    British56474600002
    LLOYD, Thomas Richard
    Little Foxwood 207 The Street
    Capel
    RH5 5ER Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Foxwood 207 The Street
    Capel
    RH5 5ER Dorking
    Surrey
    British66394670001
    LOVE, Andrew Michael
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    Geschäftsführer
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    British35693230002
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    PAYNE, Ian Timothy
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    British78974110002
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    SHAW, Anthony Brian
    79 Queensway
    W2 4QH London
    Geschäftsführer
    79 Queensway
    W2 4QH London
    British48143930001
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    STANLEY, Kate Emma
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    British66637240001
    WAGGETT, Colin
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    Geschäftsführer
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    British62266600001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat STAKIS LEISURE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Mai 2006
    Geliefert am 24. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 24. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 27. Okt. 2005
    Geliefert am 09. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 20. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Feb. 2005
    Geliefert am 18. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 17. März 2003
    Geliefert am 03. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) unit 1D fitzhardinge house,12/14 portman sq,london W1H 6LQ; NGL793166 and NGL735506;see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Erstellt am 21. Dez. 2000
    Geliefert am 11. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Kurze Angaben
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat STAKIS LEISURE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Feb. 2014Aufgelöst am
    24. Juli 2013Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jill Sandford
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nottinghamshire
    Patrick B Ellward
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Praktiker
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0