GALA LEISURE (2000) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGALA LEISURE (2000) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03458312
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GALA LEISURE (2000) LIMITED?

    • Glücksspiel- und Wettbetriebe (92000) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich GALA LEISURE (2000) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GALA LEISURE (2000) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RIVA CLUBS LIMITED16. Feb. 199816. Feb. 1998
    INTERCEDE 1289 LIMITED30. Okt. 199730. Okt. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GALA LEISURE (2000) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis24. Sept. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GALA LEISURE (2000) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für GALA LEISURE (2000) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    24 Seiten4.72

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:Replacement of liquidator
    9 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Jan. 2016

    14 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Jan. 2015

    21 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 45 Wollaton Street Nottingham Nottinghamshire NG1 5FW* am 07. Juli 2014

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Jan. 2014

    14 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England* am 22. Feb. 2013

    2 SeitenAD01

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    1 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    1 SeitenF10.2

    Änderung der Details des Direktors für Mr Harry Willits am 19. Feb. 2013

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 71 Queensway London W2 4QH United Kingdom* am 15. Feb. 2013

    1 SeitenAD01

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Nov. 2012

    Kapitalaufstellung am 19. Nov. 2012

    • Kapital: GBP 6,019,952.7
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2011

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Sept. 2010

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Diane Penfold als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von GALA LEISURE (2000) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Sekretär
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3720332
    154705870001
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    MORETON, Nigel Keef
    Sunnybank 44 Lincoln Croft
    WS14 0ND Shenstone
    Staffordshire
    Sekretär
    Sunnybank 44 Lincoln Croft
    WS14 0ND Shenstone
    Staffordshire
    British57063050001
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Sekretär
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Sekretär
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    ANSON, Paul
    The Cedars Quarry Lane
    Christleton
    CH3 7AY Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Cedars Quarry Lane
    Christleton
    CH3 7AY Chester
    Cheshire
    British56034530001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    GWILLIAM, Vincent Mitchell Lovell
    20 Flanchford Road
    Stamford Brook
    W12 9ND London
    Geschäftsführer
    20 Flanchford Road
    Stamford Brook
    W12 9ND London
    British26448890001
    KELLY, John Michael
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    Geschäftsführer
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    British56474600002
    KNIGHT, Philip John
    83 Ripley Road
    Willesborough
    TN24 0UY Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    83 Ripley Road
    Willesborough
    TN24 0UY Ashford
    Kent
    British56530830001
    MARSHALL, Diana Margaret
    18 Richmond Bridge Mansions
    Willoughby Road
    TW1 2QJ Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    18 Richmond Bridge Mansions
    Willoughby Road
    TW1 2QJ Twickenham
    Middlesex
    British48343930001
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    MORETON, Nigel Keef
    Sunnybank 44 Lincoln Croft
    WS14 0ND Shenstone
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Sunnybank 44 Lincoln Croft
    WS14 0ND Shenstone
    Staffordshire
    British57063050001
    NORTH, Brian Samuel
    Queensbury Priory Road
    Sunningdale
    SL5 9RQ Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Queensbury Priory Road
    Sunningdale
    SL5 9RQ Ascot
    Berkshire
    British6145410001
    PENFOLD, Diane June
    Cadogan Gardens
    South Woodford
    E18 1LU London
    34
    Geschäftsführer
    Cadogan Gardens
    South Woodford
    E18 1LU London
    34
    United KingdomBritish59962430002
    REEVES, Barbara
    Flat 2 24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    Geschäftsführer
    Flat 2 24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    United KingdomBritish75639030006
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill, Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    Geschäftsführer
    Hillfield
    Gorse Hill, Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    British70341190001
    SHAW, Simon John
    35 Church Road
    Boldmere
    B73 5RX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    35 Church Road
    Boldmere
    B73 5RX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British76118940001
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003

    Hat GALA LEISURE (2000) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Mai 2006
    Geliefert am 24. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 24. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 27. Okt. 2005
    Geliefert am 09. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 20. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Feb. 2005
    Geliefert am 18. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 17. März 2003
    Geliefert am 03. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) hyde rd,belle vue,manchester M18 7BA; GM770841; (ii) ainsworth st,blackburn,lancs BB1 6AF; LA786073; (iii) oasby croft,weaverthorpe retail park,tong st,bradford,yorkshire BD4 9LU; WYK493725; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 22 august 2003 and
    Erstellt am 13. März 2003
    Geliefert am 05. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the tenant's interest in the subjects known as unit 9 (formerly unit 7) links road, beach esplanade, aberdeen t/no ABN14761.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston as Security Trustee
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Erstellt am 21. Dez. 2000
    Geliefert am 11. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Kurze Angaben
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 7 august 2000 and
    Erstellt am 18. Apr. 2000
    Geliefert am 23. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due by the company to the chargee under or in connection with (1) a loan agreement dated 15 december 1997 as amended by supplemental and accession agreements of various dates (2) a hedging contract (as said term is defined in the loan agreement) (3) the deposit agreement and charge on cash deposits referred to in paragraph (b) of the definition of "charges" in the loan agreement and (4) the debenture (as the same has been amended and restated by the various supplemental and accession agreements) referred to in paragraph (a) of the definition of "charges" in the loan agreement
    Kurze Angaben
    The tenant's interest in the sub-lease of premises k/a and forming unit 9 (formerly unit 7) beach esplanade/links road,aberdeen entered into between european development company (aberdeen) limited and first leisure trading limited.t/no.ABN14761.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York as Agents and Trustee
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fourth supplemental and accession deed
    Erstellt am 18. Apr. 2000
    Geliefert am 02. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Kurze Angaben
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn road northumberland, the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 02. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 19. Juli 1999
    Geliefert am 04. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured paries under or pursuant to any of the secured documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the purchase agreement dated 30 june 1999 and the proceeds of any claim thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 18TH august 1998
    Erstellt am 05. Aug. 1998
    Geliefert am 22. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Unit 7 beach esplanade aberdeen ABN14761.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale(Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. Aug. 1998
    Geliefert am 10. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    Kurze Angaben
    F/H belle vue bingo club hyde road gorton manchester-GM770841..l/h unit a at wirral leisure centre on the west side of stadium road bromborough being riva bingo club bromborough wirral merseyside-MS370505..f/h land on the west side of granville street being riva bingo club bath row and granville street birmingham-WM601982 (for full property details see schedule). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generaleas Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 15. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policies
    Erstellt am 05. Aug. 1998
    Geliefert am 10. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All and each of the life insurance policies listed in the schedule to form 395 and all moneys which may become payable thereafter. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale(As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GALA LEISURE (2000) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Jan. 2013Beginn der Liquidation
    25. Aug. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jill Sandford
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Praktiker
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Dilip K Dattani
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Praktiker
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Patrick B Ellward
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Praktiker
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0