IRONSIDE LEISURE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameIRONSIDE LEISURE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03572523
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von IRONSIDE LEISURE LIMITED?

    • Gaststätten und Bars (56302) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich IRONSIDE LEISURE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1-3 Manor Road
    Chatham
    ME4 6AE Kent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IRONSIDE LEISURE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für IRONSIDE LEISURE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für IRONSIDE LEISURE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 09. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Vasos Lottari als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    MG01

    legacy

    MG01

    legacy

    8 SeitenMG01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008

    6 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    7 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von IRONSIDE LEISURE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TERRY, John James
    24 Railway Street
    ME4 4JT Chatham
    Kent
    Geschäftsführer
    24 Railway Street
    ME4 4JT Chatham
    Kent
    EnglandBritish55567460003
    BRICE, John Norman
    24 Railway Street
    ME4 4JT Chatham
    Kent
    Sekretär
    24 Railway Street
    ME4 4JT Chatham
    Kent
    British59530040001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    GRANGER, Simon John
    Little Mede
    Blundel Lane Stoke Dabernon
    KT11 2SF Cobham
    Surrey
    Sekretär
    Little Mede
    Blundel Lane Stoke Dabernon
    KT11 2SF Cobham
    Surrey
    British40497290005
    LOTTARI, Vasos
    52 Bluebridge Road
    Brookmans Park
    AL9 7SA Hatfield
    Hertfordshire
    Sekretär
    52 Bluebridge Road
    Brookmans Park
    AL9 7SA Hatfield
    Hertfordshire
    British85146580001
    ATKINS, James Edward Julian
    Kiss Janos Alt U 34 I E Z
    1126 Budapest
    Hungary
    Geschäftsführer
    Kiss Janos Alt U 34 I E Z
    1126 Budapest
    Hungary
    British74927610001
    BRICE, John Norman
    24 Railway Street
    ME4 4JT Chatham
    Kent
    Geschäftsführer
    24 Railway Street
    ME4 4JT Chatham
    Kent
    British59530040001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001

    Hat IRONSIDE LEISURE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 2009
    Geliefert am 07. Jan. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H 22A and 24 railway street chatham kent t/n K57844, fixtures and fittings goodwill, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Greene King Brewing and Retailing Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 13. Juni 2005
    Geliefert am 16. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Okt. 2003
    Geliefert am 08. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage 22 railway street chatham kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Okt. 2003
    Geliefert am 08. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage 22A & 24 railway street, chatham, kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Okt. 2003
    Geliefert am 08. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage 24 railway street, chatham, kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Okt. 2001
    Geliefert am 10. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H premises known as 22 22A and 24 railway street chatham t/n K57844. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Okt. 2001
    Geliefert am 23. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at 24 and 26 railway street chatham t/no: K57844. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Okt. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2001
    Geliefert am 26. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The tap and tin public house,22,22A and 24 railway st,chatham,kent; t/no K57844; all fixtures fittings and goodwill of business thereon and the benefit of any licence.
    Berechtigte Personen
    • Greene King Brewing and Retailing Limited
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Apr. 2000
    Geliefert am 13. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 22, 22A & 24 railway street chatham kent - K57844. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2000
    Geliefert am 13. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 02. März 1999
    Geliefert am 03. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £75,000.00 and any further advances due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property k/a 22, 22A & 24 railway street chatham kent t/n K57844.
    Berechtigte Personen
    • Kent Reliance Building Society
    Transaktionen
    • 03. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 03. Nov. 1998
    Geliefert am 10. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £75,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    22, 22A & 24 railway street chatham kent-K57844.
    Berechtigte Personen
    • Kent Reliance Building Society
    Transaktionen
    • 10. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0