AVOCET ESTATES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AVOCET ESTATES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03713150 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AVOCET ESTATES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich AVOCET ESTATES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 21 Sundridge Park Mansion Willoughby Lane BR1 3FL Bromley United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVOCET ESTATES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AVOCET ESTATES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2020 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2019 bis 31. März 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Change of details for Mr Bruce Paul Collins as a person with significant control on 27. Feb. 2020 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Bruce Paul Collins am 27. Feb. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 35 Homestead Road Chelsfield Orpington Kent BR6 6HN zum 21 Sundridge Park Mansion Willoughby Lane Bromley BR1 3FL am 03. Juni 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Feb. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Feb. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 037131500011, erstellt am 06. Sept. 2017 | 30 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AVOCET ESTATES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINS, Bruce Paul | Geschäftsführer | Willoughby Lane BR1 3FL Bromley 21 Sundridge Park Mansion United Kingdom | United Kingdom | British | 72822380003 | |||||
| GRAEME, Dorothy May | Bevollmächtigter Sekretär | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||
| HUNTER, Robert | Sekretär | Southenay Farm Southenay Lane Sellindge TN25 6AL Ashford Kent | British | 41789490002 | ||||||
| GRAEME, Lesley Joyce | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||
| HUNTER, Katherine | Geschäftsführer | Southenay Farm Southenay Lane, Sellindge TN25 6AL Ashford Kent | British | 63493730001 | ||||||
| HUNTER, Robert | Geschäftsführer | Southenay Farm Southenay Lane Sellindge TN25 6AL Ashford Kent | United Kingdom | British | 41789490002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AVOCET ESTATES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Bruce Paul Collins | 06. Apr. 2016 | Willoughby Lane BR1 3FL Bromley 21 Sundridge Park Mansion United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat AVOCET ESTATES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 06. Sept. 2017 Geliefert am 15. Sept. 2017 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit account charge | Erstellt am 18. Jan. 2012 Geliefert am 01. Feb. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Account number 556240-00 and sort code 08-60-68 full title guarantee by way of first fixed charge the sum of £124,000 standing to the credit of the account and all other sums with interest and includes all deposit renewals and all sums representing the proceeds of conversion of any such sum into another currency see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of rental income | Erstellt am 18. Jan. 2012 Geliefert am 27. Jan. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right, title, benefit and interest in and to the rental income see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Jan. 2012 Geliefert am 27. Jan. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land known as 2 castle road, folkestone, kent, t/no: K111926 by way of first leagl mortgage the property, together with all buildings, trade and other fixtures see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Jan. 2012 Geliefert am 27. Jan. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 07. März 2007 Geliefert am 14. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 47664142 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juli 2006 Geliefert am 04. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Juli 2006 Geliefert am 03. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 castle road folkestone kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 14. Nov. 2002 Geliefert am 15. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on west side of kennington road willesborough ashford kent t/n K584259. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Nov. 2002 Geliefert am 15. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings in wall road ashford kent t/n K497506. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Apr. 2001 Geliefert am 04. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £300,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the legal charge of even date | |
Kurze Angaben F/H little gill farm mersham kent. Being part of the land t/no. K680001. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0