CASTLEGATE 796 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CASTLEGATE 796 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03792812 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CASTLEGATE 796 LIMITED?
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten n.a. (43999) / Bauwesen
Wo befindet sich CASTLEGATE 796 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor Abbey House 32 Booth Street M2 4AB Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CASTLEGATE 796 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ANSA UTILITIES LIMITED | 23. Juni 2006 | 23. Juni 2006 |
ACTIVE SERVICES GROUP LIMITED | 21. Juni 1999 | 21. Juni 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASTLEGATE 796 LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Apr. 2021 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Apr. 2022 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2020 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CASTLEGATE 796 LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Juni 2023 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 05. Juli 2023 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
N ächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Juni 2022 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für CASTLEGATE 796 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2024 | 19 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gold Round Limited als Geschäftsführer am 26. Sept. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2023 | 21 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stuart Pace als Geschäftsführer am 14. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW United Kingdom zum 4th Floor Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB am 09. Jan. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 8 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom zum 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW am 06. Jan. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 25. Juli 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gold Round Limited am 25. Juli 2022 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 037928120009 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 037928120013 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 037928120011 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 037928120012 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed ansa utilities LIMITED\certificate issued on 10/06/22 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 21. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Albert Horton als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 29. Juni 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 18. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CASTLEGATE 796 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJP SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
BOYES, Stephen | Sekretär | Grassdale Cottage Valley Road, Houghton Bottoms PR5 0SD Preston Lancashire | British | Accouantant | 78387220001 | |||||||||
DAVIS, Peter Nicholas | Sekretär | 35 Chatsworth Road Eccles M30 9DZ Manchester Lancashire | British | Director | 29902470001 | |||||||||
DICKINSON, Louise | Sekretär | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | British | Company Director | 139480580001 | |||||||||
GRAEME, Dorothy May | Bevollmächtigter Sekretär | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||||||
MCINNES, Timothy Ian | Sekretär | 34 Cumberland Drive Bowdon WA14 3QP Altrincham Cheshire | British | Chartered Accountant | 108973030002 | |||||||||
WATKINS, Steven James | Sekretär | Roscownans Old Kea TR3 6AX Truro Cornwall | British | Director | 127928260001 | |||||||||
BARRETT, John | Geschäftsführer | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 118475070001 | ||||||||
BROOK, Philip John | Geschäftsführer | 8 Hillside Drive BH23 2RU Christchurch Dorset | British | Director | 64789650001 | |||||||||
DAVIS, Peter Nicholas | Geschäftsführer | 35 Chatsworth Road Eccles M30 9DZ Manchester Lancashire | England | British | Director | 29902470001 | ||||||||
DICKINSON, Louise | Geschäftsführer | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 139480580001 | ||||||||
GRAEME, Lesley Joyce | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||||||
HORTON, Alan Albert | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | Director | 182208240001 | ||||||||
LEE, Peter Francis | Geschäftsführer | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 207608120001 | ||||||||
LEES, Stuart | Geschäftsführer | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | England | British | Director | 70032700001 | ||||||||
LLOYD JONES, Andrew Mark | Geschäftsführer | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 180809810001 | ||||||||
MAHONEY, Kevin David | Geschäftsführer | 6 Ferrymans Quay William Morris Way SW6 2UT London | United Kingdom | British | Company Director | 63238350002 | ||||||||
MAUDE, Simon David | Geschäftsführer | The Main Hall Rufford Park Lane Rufford L40 1XE Ormskirk 1 Lancashire | United Kingdom | British | Director | 89719660003 | ||||||||
MCINNES, Timothy Ian | Geschäftsführer | 34 Cumberland Drive Bowdon WA14 3QP Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 108973030002 | ||||||||
PACE, Stuart | Geschäftsführer | Abbey House 32 Booth Street M2 4AB Manchester 4th Floor | England | British | Director | 207506130003 | ||||||||
POLLARD, Niall Mackinlay | Geschäftsführer | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | England | British | Director | 176786520001 | ||||||||
SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | United Kingdom | British | Director | 207506140001 | ||||||||
TURNER, Paul Leslie | Geschäftsführer | Netherlaw Greendale Lane SK10 4AY Mottram St Andrew Cheshire | British | Director | 72964390004 | |||||||||
VINCENT, Michael | Geschäftsführer | 23 Saint Aubyns's Avenue SW19 7BL London | England | British | Finance Director | 99258270001 | ||||||||
WATKINS, Steven James | Geschäftsführer | Park Crescent TR11 2DL Falmouth 1 Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 127928260002 | ||||||||
WATKINS, Steven James | Geschäftsführer | Roscownans Old Kea TR3 6AX Truro Cornwall | British | Director | 127928260001 | |||||||||
GOLD ROUND LIMITED | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 149588400001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CASTLEGATE 796 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Round Limited | 18. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Gold Round Limited | 06. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Iguk Support Services Limited | 06. Apr. 2016 | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CASTLEGATE 796 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 01. Sept. 2016 Geliefert am 13. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 03. Juni 2016 Geliefert am 20. Juni 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 03. Juni 2016 Geliefert am 17. Juni 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 18. Apr. 2016 Geliefert am 21. Apr. 2016 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 18. Apr. 2016 Geliefert am 21. Apr. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite gaurantee and debenture | Erstellt am 26. Juni 2009 Geliefert am 02. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Juni 2009 Geliefert am 30. Juni 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Accession deed | Erstellt am 30. Juni 2005 Geliefert am 06. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The payment of the secured liabilities,any f/h or l/h property,its interest in present and future licences,fixed charge all othe present and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Juni 2004 Geliefert am 02. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Sept. 2002 Geliefert am 13. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Sept. 2001 Geliefert am 27. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 27. Juli 2000 Geliefert am 02. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat CASTLEGATE 796 LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0