GGHII LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GGHII LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03936658 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GGHII LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich GGHII LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | New Castle House Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham Nottinghamshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GGHII LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GALA GROUP HOLDINGS II LIMITED | 27. März 2003 | 27. März 2003 |
GALA GROUP HOLDINGS LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 |
LAUNCHVOTE PUBLIC LIMITED COMPANY | 29. Feb. 2000 | 29. Feb. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GGHII LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 26. Sept. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GGHII LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2016 bis 31. März 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed gala group holdings ii LIMITED\certificate issued on 02/12/16 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Carl Anthony Leaver als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Harry Willits als Direktor am 13. Sept. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gala Coral Nominees Limited als Geschäftsführer am 13. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gala Coral Secretaries Limited als Sekretär am 13. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Sept. 2015 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Gala Coral Secretaries Limited am 15. Feb. 2013 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gala Coral Nominees Limited am 15. Feb. 2013 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 11. Sept. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Sept. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GGHII LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOWTELL, Paul | Geschäftsführer | Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham New Castle House Nottinghamshire England | United Kingdom | British | Executive | 164343080001 | ||||||||
TEMPLEMAN, Robert William | Geschäftsführer | Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham New Castle House Nottinghamshire England | United Kingdom | British | Non Executive Chairman | 159382420002 | ||||||||
WILLITS, Harry Andrew | Geschäftsführer | Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham New Castle House Nottinghamshire | United Kingdom | British | Solicitor | 175965490001 | ||||||||
CHEATLE, Martyn David | Sekretär | The Retreat 81 Wales Lane Barton Under Needwood DE13 8JG Burton On Trent Staffordshire | British | Company Secretary | 149874460001 | |||||||||
SINTON, Charles Blair Ritchie | Sekretär | The Mill House Old Mill Lane SL6 2BG Bray Berkshire | British | 52292450003 | ||||||||||
SMERDON, Leigh | Sekretär | 1 Cedar Grove The Hedgerows Great Wyrley WS6 6QH Walsall West Midlands | Other | Chartered Secretary | 89075910001 | |||||||||
GALA CORAL SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham New Castle House Nottinghamshire England |
| 69240850005 | ||||||||||
SISEC LIMITED | Sekretär | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 38545840001 | |||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
CRONK, John Julian Tristam | Geschäftsführer | Glebe House Vicarage Drive IG11 7NS Barking Essex | British | Company Secretary | 6422100001 | |||||||||
D'JANOEFF, Alexander Constantine Basil | Geschäftsführer | Flat 3 Avenue Court Draycott Avenue SW3 3BU London | British | Manager | 69177260001 | |||||||||
GOULDEN, Neil Geoffrey | Geschäftsführer | Queensway W2 4QH London 71 England | England | British | Director | 151637880001 | ||||||||
GOULDEN, Neil Geoffrey | Geschäftsführer | New Castle House Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 21686380006 | ||||||||
GOULDEN, Neil Geoffrey | Geschäftsführer | One The Shires RG41 4SZ Wokingham Berkshire | England | British | Director | 21686380003 | ||||||||
HARRISON, Dominic Stephen | Geschäftsführer | Glebe House Vicarage Drive IG11 7NS Barking Essex | United Kingdom | British | Chief Executive | 107909600001 | ||||||||
HUGHES, Gary William | Geschäftsführer | Queensway 71 Queensway W2 4QH London 71 England | Scotland | British | Chief Financial Officer | 151269910001 | ||||||||
KELLY, John Michael | Geschäftsführer | New Castle House Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 141916500001 | ||||||||
LEAVER, Carl Anthony | Geschäftsführer | Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham New Castle House Nottinghamshire England | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 159381090001 | ||||||||
LOHSEN, Kenneth John | Geschäftsführer | 61 Arbor Field Way Lake Grove 11755 New York Usa | American | Accountant | 78873190001 | |||||||||
MACKINTOSH, Alistair Angus | Geschäftsführer | Whitecroft Tilford Road GU9 8HX Farnham Surrey | British | Director | 77057990004 | |||||||||
MATTINGLEY, Brian Roger | Geschäftsführer | York House Kennedy Close SL7 3JA Marlow Buckinghamshire | British | Company Director | 22417130001 | |||||||||
PERPER, Reid Samuel | Geschäftsführer | 86 Palace Gardens Terrace W8 4RS London | Usa | Managing Director | 80013810001 | |||||||||
ROBERTS, Edward Matthew Giles | Geschäftsführer | Gala Group Limited New Castle House Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham Nottinghamshire | British | Director | 100607290001 | |||||||||
SANKEY, Vernon Louis | Geschäftsführer | The Cherubs Parsonage Lane, Farnham Common SL2 3NZ Slough Berkshire | British | Director | 24166110004 | |||||||||
SINTON, Charles Blair Ritchie | Geschäftsführer | The Mill House Old Mill Lane SL6 2BG Bray Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 52292450003 | ||||||||
SOWERBY, Richard Thomas Neville | Geschäftsführer | New Castle House Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 47734920003 | ||||||||
SOWERBY, Richard Thomas Neville | Geschäftsführer | Oakmead Farm Ockham Lane KT13 8EN Cobham Surrey | England | British | Director | 47734920002 | ||||||||
TAYLOR, Colin Andrew | Geschäftsführer | 8 Abbotsbury Close W14 8EG London | Canadian | Managing Director | 80013570001 | |||||||||
TURNER, Matthew Charles | Geschäftsführer | Springfield Hall Star Lane Knowl Hill RG10 9UR Reading Berkshire | United Kingdom | British | Venture Capitalist | 115927000001 | ||||||||
WINCKLES, Richard | Geschäftsführer | Flat 41 2 Mansfield Street W1M 9FF London | British | Banker | 69958990004 | |||||||||
GALA CORAL NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham New Castle House England |
| 76454320002 | ||||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||||||
LOVITING LIMITED | Geschäftsführer | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 38761350001 | |||||||||||
SERJEANTS'INN NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 38761340001 | |||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GGHII LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ggtii Limited | 06. Apr. 2016 | Castle Boulevard NG7 1FT Nottingham New Castle House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat GGHII LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating security document | Erstellt am 27. Mai 2011 Geliefert am 10. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor or any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security document | Erstellt am 11. Mai 2006 Geliefert am 24. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security document | Erstellt am 27. Okt. 2005 Geliefert am 09. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged please refer to form 3. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security document | Erstellt am 01. Sept. 2005 Geliefert am 20. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security document | Erstellt am 11. Feb. 2005 Geliefert am 18. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security document | Erstellt am 17. März 2003 Geliefert am 03. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 17. Apr. 2000 Geliefert am 28. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers (as defined) to the chargee under the facilities agreement (as defined) | |
Kurze Angaben All rights under or in connection with the gala sale agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0