NPS (UK8) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NPS (UK8) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04045673 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NPS (UK8) LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich NPS (UK8) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NPS (UK8) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NORTHGATE.NET LIMITED | 09. Jan. 2009 | 09. Jan. 2009 |
| ANITE.NET LIMITED | 11. Aug. 2000 | 11. Aug. 2000 |
| HALLCO 484 LIMITED | 02. Aug. 2000 | 02. Aug. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NPS (UK8) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NPS (UK8) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW zum 15 Canada Square London E14 5GL am 03. Mai 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2019 bis 31. März 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Michael Noble als Geschäftsführer am 06. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen James Callaghan am 06. Aug. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Apr. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ian Michael Noble als Direktor am 06. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Coll als Geschäftsführer am 06. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen James Callaghan als Direktor am 10. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Meaden als Geschäftsführer am 10. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed northgate.net LIMITED\certificate issued on 16/06/15 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von David John Meaden als Direktor am 22. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NPS (UK8) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
| CALLAGHAN, Stephen James | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 201347710052 | |||||||||
| BEATON, Richard L'Estrange | Sekretär | Prestbury Hall The Village SK10 4BN Prestbury Cheshire | British | 97291590001 | ||||||||||
| COUTTS, Cheryl Jane | Sekretär | 6 Esmond Road W4 1JQ Chiswick London | British | 12016130002 | ||||||||||
| COX, Melanie Rachel | Sekretär | 1 The Green Bisham SL7 1RY Marlow Buckinghamshire | British | 96139050001 | ||||||||||
| HEMMING, Vivienne Ruth | Sekretär | 25 Saint Johns Road OX10 9AW Wallingford Oxon | British | 41962390006 | ||||||||||
| HUMPHREY, Christopher John | Sekretär | Well House School Lane, Northend BA1 7EP Bath Somerset | British | 32877720003 | ||||||||||
| HUNT, Simon Anthony | Sekretär | Apt 31 21 Sheldon Square Paddington Central W2 6DS London | British | 118771650001 | ||||||||||
| RICHARDSON, John David | Sekretär | High Street Burnham SL1 7JD Slough 27 Berks | British | 128558470001 | ||||||||||
| SADLER, John Michael | Sekretär | 14 Highlands Close SL9 0DR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78431540001 | ||||||||||
| SCHENCK, Daniel William | Sekretär | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||||||
| WENMAN, Nicholas Edward | Sekretär | Three Gates 40a Guildown Road GU2 5EY Guildford Surrey | British | 14373460003 | ||||||||||
| HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013280001 | |||||||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Geschäftsführer | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | 165900220001 | |||||||||
| BASS, Neil Anthony | Geschäftsführer | 31 Archery Fields RG29 1AE Odiham Hampshire | England | British | 70199330002 | |||||||||
| BEATON, Richard L'Estrange | Geschäftsführer | Prestbury Hall The Village SK10 4BN Prestbury Cheshire | England | British | 97291590001 | |||||||||
| COLL, Andrew | Geschäftsführer | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 237260100001 | |||||||||
| GIBSON, John Leonard | Geschäftsführer | Ivydene Delly End OX29 9XD Hailey Oxfordshire | British | 104554430001 | ||||||||||
| HUNT, Simon Anthony | Geschäftsführer | Apt 31 21 Sheldon Square Paddington Central W2 6DS London | British | 118771650001 | ||||||||||
| MCCANN, James | Geschäftsführer | 32 Carter Close SL4 3QX Windsor Berkshire | British | 69923680001 | ||||||||||
| MEADEN, David John | Geschäftsführer | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 193740420001 | |||||||||
| NOBLE, Ian Michael | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 199843940001 | |||||||||
| SLOGGETT, David Raymond, Dr | Geschäftsführer | 12 Mcnaughton Close GU14 0PX Farnborough Hampshire | British | 34112730001 | ||||||||||
| STIER, John Robert | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78901530003 | |||||||||
| STONE, Christopher Michael Renwick | Geschäftsführer | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 66955690003 | |||||||||
| TAIT, Ian | Geschäftsführer | Field House Evesham Road WR10 2QR Fladbury Worcestershire | United Kingdom | British | 76976490001 | |||||||||
| THORPE, David Allan | Geschäftsführer | Bobble Barn Farmhouse GL54 2ND Little Rissington Gloucestershire | United Kingdom | British | 77702540001 | |||||||||
| TYRRELL, Simon Robert Edgar | Geschäftsführer | Larks 15 Burstead Close KT11 2NL Cobham Surrey | England | British | 77284710002 | |||||||||
| WENMAN, Nicholas Edward | Geschäftsführer | Three Gates 40a Guildown Road GU2 5EY Guildford Surrey | British | 14373460003 | ||||||||||
| HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013270001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NPS (UK8) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nps (Uk5) Limited | 06. Apr. 2016 | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat NPS (UK8) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006 | Erstellt am 16. Feb. 2007 Geliefert am 01. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006 | Erstellt am 15. Feb. 2007 Geliefert am 01. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 28. Nov. 2006 Geliefert am 30. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002 | Erstellt am 28. Feb. 2006 Geliefert am 02. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus letter of set-off | Erstellt am 09. Dez. 2002 Geliefert am 13. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat NPS (UK8) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0