TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04346502 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THISTLE EDINBURGH LIMITED | 01. März 2002 | 01. März 2002 |
| PETERTRAIL LIMITED | 03. Jan. 2002 | 03. Jan. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Mai 2013 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 28. Feb. 2014 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Jan. 2017 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Nov. 2016 | 10 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 5 Seiten | 600 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | AC93 | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Sept. 2014 | 6 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. März 2014 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Cheryl Frances Moharm am 07. Jan. 2013 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Eddie Zakay am 03. Apr. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHARM, Cheryl Frances | Sekretär | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | British | 74265400001 | ||||||
| BUSH, Clive Edward | Geschäftsführer | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | England | British | 62062860002 | |||||
| MOHARM, Cheryl Frances | Geschäftsführer | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | United Kingdom | British | 74265400003 | |||||
| ZAKAY, Eddie | Geschäftsführer | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | United Kingdom | British | 8477470004 | |||||
| BAXANDALL, Catherine Elizabeth | Sekretär | Bordley Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 27825440001 | ||||||
| CATTERMOLE, Ian Kendall | Sekretär | Spindlewood Coppins Close HP4 3NZ Berkhamsted Hertfordshire | British | 82666030001 | ||||||
| DURANT, Ian Charles | Sekretär | 57 The Avenue Kew TW9 2AL Richmond Surrey | British | 150020002 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| BAXANDALL, Catherine Elizabeth | Geschäftsführer | Bordley Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 27825440001 | ||||||
| CATTERMOLE, Ian Kendall | Geschäftsführer | Spindlewood Coppins Close HP4 3NZ Berkhamsted Hertfordshire | British | 82666030001 | ||||||
| DURANT, Ian Charles | Geschäftsführer | 57 The Avenue Kew TW9 2AL Richmond Surrey | United Kingdom | British | 150020002 | |||||
| FAIRLEY, Neil Duff | Geschäftsführer | 72 Carr Road Calverley LS28 5RH Leeds West Yorkshire | England | British | 78198900001 | |||||
| LAYTON, Matthew Robert | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| MOK, Rayman | Geschäftsführer | PO BOX 44790 101 Buckingham Palace Road SW1W 0WA London | Singaporean | 101871540001 | ||||||
| NEWSOME, Gillian Anne | Geschäftsführer | 15 Layton Lane Rawdon LS19 6RQ Leeds West Yorkshire | British | 70404230001 | ||||||
| O'MAHONEY, Michael | Geschäftsführer | 44 Beechcroft Manor KT13 9NZ Weybridge Surrey | British | 84990810001 | ||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| WILDEN, Nichola Jane | Geschäftsführer | 12c Elsworthy Terrace NW3 3DR London | England | British | 24856300002 | |||||
| ZAKAY, Sol | Geschäftsführer | 46 Avenue Road NW8 6HS London | United Kingdom | British | 26053220007 |
Hat TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A standard security presented for registration in scotland on the 3RD may 2005 and | Erstellt am 28. Apr. 2005 Geliefert am 18. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limted to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the tenants interest in the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh being the lease between murrayfield (tolcross) limited and scottish and newcastle breweries limited dated the 6TH may, 11TH july and 9TH august 1974. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents on 4TH may 2005 | Erstellt am 28. Apr. 2005 Geliefert am 18. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limited to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company`s whole right title and interest in and to the rent and all other monies due and to become due to the company in terms of the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh dated the 28TH april 2005. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 28. Apr. 2005 Geliefert am 07. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The tenant's interest in the lease of the thistle hotel st james centre edinburgh t/no MID22327. By way of fixed charge all moneys standing to the credit of the charged accounts, the benefits in respect of the insurances, all rights under each occupational lease, the benefit of all licences, all rights under the assigned agreements, all shares and related rights. By way of floating charge the assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TOPLAND HOTELS (EDINBURGH) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0