SWAMF NOMINEE (2) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSWAMF NOMINEE (2) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04784136
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SWAMF NOMINEE (2) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich SWAMF NOMINEE (2) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SWAMF NOMINEE (2) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SACKVILLE TCI PROPERTY NOMINEE (2) LIMITED18. Jan. 200518. Jan. 2005
    DELETENUMBER LIMITED02. Juni 200302. Juni 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SWAMF NOMINEE (2) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für SWAMF NOMINEE (2) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 33 Old Broad Street London EC2N 1HZ zum 1 More London Place London SE1 2AF am 31. Juli 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Juli 2019

    LRESSP

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Juni 2018 bis 28. Juni 2018

    3 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2018 bis 29. Juni 2018

    3 SeitenAA01

    Erfüllung der Belastung 21 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 37 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 34 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 33 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 45 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 30 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 43 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 41 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 54 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 55 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von SWAMF NOMINEE (2) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Sekretär
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02791894
    73512200003
    MCGOWAN, Iain Ross
    Lloyds Banking Group Plc
    69 Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    Insurance Company Secretariat
    Scotland
    Scotland
    Geschäftsführer
    Lloyds Banking Group Plc
    69 Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    Insurance Company Secretariat
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish185958620001
    WILLIAMS, Marie Elaine
    Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    69
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    69
    United Kingdom
    EnglandBritish206388510001
    DARLING, Shona Mary
    Flat 11
    76 Eyre Place
    EH3 5EZ Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    Flat 11
    76 Eyre Place
    EH3 5EZ Edinburgh
    Midlothian
    British110522070002
    KAYE, Alan
    15 Edge Hill Avenue
    N3 3AY London
    Sekretär
    15 Edge Hill Avenue
    N3 3AY London
    British21908430001
    SMITH, Kate Susan
    Drylawhill
    East Linton
    EH40 3AZ East Lothian
    7
    Sekretär
    Drylawhill
    East Linton
    EH40 3AZ East Lothian
    7
    Other132379630001
    SPV MANAGEMENT LIMITED
    Tower 42 Level 11 International
    Financial Centre 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Sekretär
    Tower 42 Level 11 International
    Financial Centre 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    24311810008
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAKER, Robin Gregory
    Doddinghurst Road
    CM15 9EH Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Doddinghurst Road
    CM15 9EH Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish35557610004
    CHANNING, Michael Francis Arthur
    19 Seton Place
    EH9 2JT Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    19 Seton Place
    EH9 2JT Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish101660670001
    CLATWORTHY, James Edward
    Lloyds Banking Group Plc
    69 Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    Insurance Company Secretariat
    Scotland
    Scotland
    Geschäftsführer
    Lloyds Banking Group Plc
    69 Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    Insurance Company Secretariat
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritish157147450001
    FAIRRIE, James Patrick Johnston
    5 Templars Crescent
    Finchley
    N3 3QR London
    Geschäftsführer
    5 Templars Crescent
    Finchley
    N3 3QR London
    British45091610001
    FERGUSON, James Gerard
    Boclair Road
    G64 2NB Glasgow
    23
    Geschäftsführer
    Boclair Road
    G64 2NB Glasgow
    23
    United KingdomBritish100078130002
    HUNTER, Kerri
    60 Morrison Street
    EH3 8BE Edinburgh
    Edinburgh One
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    60 Morrison Street
    EH3 8BE Edinburgh
    Edinburgh One
    United Kingdom
    United KingdomBritish166233600001
    JORDISON, Donald
    117 The Avenue
    Ealing
    W13 8JT London
    Geschäftsführer
    117 The Avenue
    Ealing
    W13 8JT London
    British79821950001
    LAIDLAW, Thomas Baillie
    15 Liberton Drive
    EH16 6NL Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    15 Liberton Drive
    EH16 6NL Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish61231540001
    MURRAY, Cameron Shaun
    Stafford Street
    EH3 7BD Edinburgh
    32a
    Geschäftsführer
    Stafford Street
    EH3 7BD Edinburgh
    32a
    British115949270001
    NAISH, Robert Malcolm
    Morrison Street
    EH3 8BE Edinburgh
    60
    Uk
    Geschäftsführer
    Morrison Street
    EH3 8BE Edinburgh
    60
    Uk
    United KingdomBritish3418680003
    NOVEMBER, Andrew John
    16 Netherby Road
    EH5 3NA Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    16 Netherby Road
    EH5 3NA Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish98649160001
    PATCH, Nicholas
    72 Calshot Avenue
    Chafford Hundred
    RM16 6NS Grays
    Essex
    Geschäftsführer
    72 Calshot Avenue
    Chafford Hundred
    RM16 6NS Grays
    Essex
    British90777110001
    RIGG, James Mark Alexander
    3b Marjorie Grove
    SW11 5SH London
    Geschäftsführer
    3b Marjorie Grove
    SW11 5SH London
    British67445210001
    STRANG, Andrew David
    Woodcote Lodge
    Snows Ride
    GU20 6PE Windlesham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodcote Lodge
    Snows Ride
    GU20 6PE Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish3903450001
    WARD, Daniel
    7 First Street
    SW3 2LB London
    Geschäftsführer
    7 First Street
    SW3 2LB London
    British40210560002
    WILLCOCK, John Marcus
    21 Gartons Road
    Middleleaze
    SN5 5TR Swindon
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    21 Gartons Road
    Middleleaze
    SN5 5TR Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish76276580001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SPV MANAGEMENT LIMITED
    Tower 42 Level 11 International
    Financial Centre 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Geschäftsführer
    Tower 42 Level 11 International
    Financial Centre 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    24311810008

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SWAMF NOMINEE (2) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUk
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer04736787
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat SWAMF NOMINEE (2) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 15. Apr. 2004
    Geliefert am 16. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 26A, 26B and 26C albermarle street london t/no NGL55986; all buildings and other structures on, and items fixed to, the property; any goodwill relating to the property or the business or undertaking conducted at the property; all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property on or at any time after the date of this charge; and the proceeds of any claim made under any insurance policy.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Aug. 2003
    Geliefert am 09. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property st george's house, 56 peter street, manchester t/n GM683062 by way of fixed charge all buildings and other structures, any goodwill relating to the property, all plant machinery and other items. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 19/08/03 and dated 15/08/03 and
    Erstellt am 18. Aug. 2003
    Geliefert am 01. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects at and k/a 82,84,86,88,90 and 92 kilmarnock road glasgow t/n GLA137798. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 29, 30 and 33 herschel street and 1 to 5 (odd) alpha street, slough (together k/a pegasus court) t/nos. BK225924 and BK277522 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 165 high street, poole, dorset t/no. DT140515 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a units 2, 3 and 4 canal walk, toomers wharf, newbury, berkshire t/no. BK357446 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a units 1-4, the parade, minehead, somerset t/no. ST61537 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 1-28 heathfield, stacey bushes industrial park, milton keynes t/no. BM251403 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a cornwallis house, instone road, dartford t/no. K597229 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the market centre, crewe t/nos. CH245256, CH245258 and CH406334 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a ashby house, (formerly part of globe house) new street, chelmsford, essex and ancillary parking t/nos. EX574280 and EX596148 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the east side of stony lane, christchurch, dorset t/no. DT142638 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a beta unit, woodlands lane, almondsbury, bristol t/no. GR214120 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 1-40 bury street, abingdon t/nos. BK93727, ON72730, ON120560 and BK66269 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a burryport road, northampton t/no. NN125001 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a kelpatrick road, slough (also k/a land at the rear of 452 bath road, slough) t/no. BK363084 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a west wiltshire trading estate, quarter master road, westbury, wiltshire t/nos. WT817693, WT180603 and WT114935 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a units 1 and 2 bescot crescent, walsall t/no. WM722589 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a sites g, h and I, west howe industrial estate, bournemouth t/no. DT196981 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a chatsworth walk, cornfield road, eastbourne t/nos. EB7613 and ESX90369 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 134 terminus road, eastbourne t/no. EB13780 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 35, 36 and 37 market place and land forming part of 37 high street, dudley, west midlands t/nos. WM299639 and WM390939 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 68 english street and 1 highland laddie lane, carlisle, cumbria t/no. CU67020 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a neville house, mount ephraim, tunbridge wells, kent t/no. K518439 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 23. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a former homebase unit, area 3C pagoda west, westmead industrial estate, swindon t/no. WT73885 by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the property, any goodwill relating to the property, all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat SWAMF NOMINEE (2) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Juli 2019Beginn der Liquidation
    13. März 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0