PIPEX STRUCTURAL COMPOSITES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PIPEX STRUCTURAL COMPOSITES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05073984 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PIPEX STRUCTURAL COMPOSITES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich PIPEX STRUCTURAL COMPOSITES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O National Oilwell Varco Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Gloucestershire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PIPEX STRUCTURAL COMPOSITES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PIPEX STRUCTURAL COMPOSITES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alastair James Fleming als Geschäftsführer am 31. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Scott Reid als Direktor am 09. Juli 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 31. März 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2015 bis 31. März 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Pipex House Devon Enterprise Facility 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth PL6 7BP zum C/O National Oilwell Varco Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ am 17. Dez. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Alison May Sloan als Sekretär am 25. Nov. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Alastair James Fleming als Direktor am 25. Nov. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robbert Oudendijk als Direktor am 25. Nov. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PIPEX STRUCTURAL COMPOSITES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOAN, Alison May | Sekretär | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 203598680001 | |||||||||||
| OUDENDIJK, Robbert | Geschäftsführer | 2806 Hh Gouda Tobias Asserstraat 1 Netherlands | Netherlands | Dutch | 201609020001 | |||||||||
| REID, Simon Scott | Geschäftsführer | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 248254430001 | |||||||||
| MURPHY, William Joseph | Sekretär | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | British | 99265470001 | ||||||||||
| SMITH, Alan William Bedford | Sekretär | Smiths Wood Cottage Sigford TQ12 6LE Newton Abbot Devon | British | 17572740002 | ||||||||||
| WRIGHT, Steven | Sekretär | 38 Fairfield Sampford Peverell EX16 7DE Tiverton Devon | British | 61971200001 | ||||||||||
| CURZON CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Grenadier Road EX1 3LH Exeter Ashford House Devon United Kingdom |
| 65608250008 | ||||||||||
| MICHELMORES SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Pynes Hill EX2 5WR Exeter Woodwater House United Kingdom |
| 107218000001 | ||||||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||||||
| BYRNE, Thomas Paul | Geschäftsführer | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | England | Irish | 109463760001 | |||||||||
| EVES, Simon | Geschäftsführer | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | Scotland | British | 99574020001 | |||||||||
| FLEMING, Alastair James | Geschäftsführer | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 180854890001 | |||||||||
| HEWSTONE, Matthew John | Geschäftsführer | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | United Kingdom | British | 108288160001 | |||||||||
| KENNETT, Adrian Peter | Geschäftsführer | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | United Kingdom | British | 76174650001 | |||||||||
| MURPHY, William Joseph | Geschäftsführer | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | England | British | 99265470001 | |||||||||
| RAYNOR, Sarah Jane | Geschäftsführer | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | United Kingdom | British | 134075280002 | |||||||||
| SMITH, Alan William Bedford | Geschäftsführer | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | England | British | 17572740002 | |||||||||
| SMITH, Timothy Alan Bedford | Geschäftsführer | Yarde Down Silverton EX45 4DG Exeter South Barn Devon | United Kingdom | British | 271454710001 | |||||||||
| SMITH, Tom Henry Bedford | Geschäftsführer | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | United Kingdom | British | 108224760001 | |||||||||
| STAIT, Geraint Wynn | Geschäftsführer | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | United Kingdom | British | 138600240001 | |||||||||
| WRIGHT, Steven | Geschäftsführer | Pipex House Devon Enterprise Facility PL6 7BP 1 Belliver Way (Off Haxter Close), Plymouth | England | British | 61971200001 | |||||||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PIPEX STRUCTURAL COMPOSITES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipex Limited | 06. Apr. 2016 | Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse C/O National Oilwell Varco Gloucestershire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PIPEX STRUCTURAL COMPOSITES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 19. Jan. 2012 Geliefert am 21. Jan. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in pound sterling designated ltsb re: pipex structural composites limited and numbered 22037468 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 12. Dez. 2005 Geliefert am 16. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the companies with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 20. Sept. 2004 Geliefert am 29. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0