EGX LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EGX LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05452541 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EGX LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich EGX LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Suite A, 7th Floor City Gate East NG1 5FS Tollhouse Hill Nottingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EGX LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SUN STAY LTD | 13. Mai 2005 | 13. Mai 2005 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EGX LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EGX LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 107 Station Street Burton-on-Trent Staffordshire DE14 1SZ England zum Suite a, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS am 25. Nov. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 14 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 17 Seiten | MA | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 24. Okt. 2019
| 6 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 24. Okt. 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2018 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr John Spencer Sheridan als Direktor am 30. Aug. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Darryn Stanley Gibson als Direktor am 23. Mai 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Edward Roderick als Geschäftsführer am 08. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Edward Roderick als Direktor am 17. Mai 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Stevens als Geschäftsführer am 17. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Fifth Avenue Centrum 100 Burton on Trent Staffordshire DE14 2WS zum 107 Station Street Burton-on-Trent Staffordshire DE14 1SZ am 15. Mai 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EGX LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADSHAW, John | Sekretär | City Gate East NG1 5FS Tollhouse Hill Suite A, 7th Floor Nottingham | 183398930001 | |||||||
| BRADSHAW, John Richard | Geschäftsführer | City Gate East NG1 5FS Tollhouse Hill Suite A, 7th Floor Nottingham | United Kingdom | British | 224052330001 | |||||
| GIBSON, Darryn Stanley | Geschäftsführer | City Gate East NG1 5FS Tollhouse Hill Suite A, 7th Floor Nottingham | England | New Zealander | 245702030001 | |||||
| SHERIDAN, John Spencer | Geschäftsführer | City Gate East NG1 5FS Tollhouse Hill Suite A, 7th Floor Nottingham | England | British | 238643210001 | |||||
| DWYER, Daniel John | Sekretär | Goldfinch Close Chelsfield BR6 6NF Orpington 14 Kent | British | 112335920001 | ||||||
| ROBERTS, Sharon Mary | Sekretär | 6 Hillwood Road Four Oaks B75 5QL Sutton Coldfield West Midlands | British | 78653860002 | ||||||
| WHITE, Graham Roger | Sekretär | Fifth Avenue Centrum 100 Burton On Trent DE14 2WS Staffordshire | 181719660001 | |||||||
| WHITE, Graham Roger | Sekretär | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | 62438660003 | ||||||
| CLINTON, Julia | Geschäftsführer | Perton Road WV6 8DJ Wolverhampton 50 United Kingdom | England | British | 153887120001 | |||||
| COHEN, Jonathan Edward | Geschäftsführer | 39 Park Lane Roundhay LS8 2EH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 71405040001 | |||||
| DWYER, Daniel James | Geschäftsführer | Clovers End Patcham BN1 8PJ Brighton 2 East Sussex | United Kingdom | British | 86094440001 | |||||
| FEATHERSTONE, James Michael, Dr | Geschäftsführer | Fifth Avenue Centrum 100 Burton On Trent DE14 2WS Staffordshire | England | British | 199344900002 | |||||
| GORDON, Michael Andrew | Geschäftsführer | Fifth Avenue Centrum 100 Burton On Trent DE14 2WS Staffordshire | England | British | 56076310002 | |||||
| GRAFF, Anthony Daniel | Geschäftsführer | Fifth Avenue Centrum 100 Burton On Trent DE14 2WS Staffordshire | England | English | 128576530001 | |||||
| HODGSON, Jonathan Andrew | Geschäftsführer | Plumley Moor Road Plumley WA16 9SB Knutsford 93 Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 119903450002 | |||||
| JONES, Edward Gareth, Dr | Geschäftsführer | Manor Barn Lyndon Road, Manton LE15 8SR Oakham Leicestershire | England | British | 70448220001 | |||||
| POOLE, Jennifer Ruth | Geschäftsführer | Fifth Avenue Centrum 100 Burton On Trent DE14 2WS Staffordshire | United Kingdom | British | 70448020003 | |||||
| RODERICK, Mark Edward | Geschäftsführer | Station Street DE14 1SZ Burton-On-Trent 107 Staffordshire England | England | British | 231004120001 | |||||
| SMITH, Mark Robert | Geschäftsführer | Fifth Avenue Centrum 100 Burton On Trent DE14 2WS Staffordshire | United Kingdom | British | 101494660002 | |||||
| STEVENS, Matthew | Geschäftsführer | Station Street DE14 1SZ Burton-On-Trent 107 Staffordshire England | England | British | 197656180001 | |||||
| WALSH, Charles Anthony | Geschäftsführer | Flat 7 25 Luxborough Street W1U 5AR London | England | Irish | 36957990002 | |||||
| WHITE, Graham Roger | Geschäftsführer | Fifth Avenue Centrum 100 Burton On Trent DE14 2WS Staffordshire | England | British | 257851790001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EGX LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonaut Bidco Limited | 06. Apr. 2016 | Station Street DE14 1SZ Burton-On-Trent 107 Staffordshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EGX LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Erstellt am 01. Feb. 2012 Geliefert am 02. Feb. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 31. Aug. 2007 Geliefert am 07. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Dez. 2005 Geliefert am 07. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat EGX LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0