TISSUE REGENIX LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TISSUE REGENIX LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05807272 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TISSUE REGENIX LIMITED?
- Andere Forschung und experimentelle Entwicklung in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen (72190) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TISSUE REGENIX LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 3, Phoenix Court Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TISSUE REGENIX LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für TISSUE REGENIX LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Apr. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 05. Mai 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Apr. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für TISSUE REGENIX LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Eintragung der Belastung 058072720006, erstellt am 23. Dez. 2025 | 67 Seiten | MR01 | ||
Ernennung von Miss Kirsten Mary Lund als Direktor am 16. Okt. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Daniel Ray Lee als Geschäftsführer am 15. Okt. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Jay Charles Lecoque als Direktor am 04. Sept. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Martin Glenn als Geschäftsführer am 05. Sept. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 24 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von David Claiborne Cocke als Geschäftsführer am 31. Juli 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 23 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 24 Seiten | AA | ||
Eintragung der Belastung 058072720004, erstellt am 27. Jan. 2023 | 64 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 058072720005, erstellt am 27. Jan. 2023 | 64 Seiten | MR01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 25 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 31 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Daniel Lee am 20. Aug. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr David Claiborne Cocke als Direktor am 21. Jan. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 28 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Jonathan Martin Glenn als Direktor am 03. Dez. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Jonathan Richard Miller als Geschäftsführer am 03. Dez. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Gareth Hywel Jones als Geschäftsführer am 24. Nov. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Daniel Lee als Direktor am 16. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von TISSUE REGENIX LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUND, Kirsten Mary | Sekretär | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | 265561930001 | |||||||||||
| LECOQUE, Jay Charles | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 340125000001 | |||||||||
| LUND, Kirsten Mary | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 341789650001 | |||||||||
| DEVLIN, Paul John | Sekretär | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 222138520001 | |||||||||||
| JEFFERSON, Ian David | Sekretär | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 169191130001 | |||||||||||
| JONES, Gareth Hywel | Sekretär | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | 252393110001 | |||||||||||
| IP2IPO SERVICES LIMITED | Sekretär | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire United Kingdom |
| 122951520001 | ||||||||||
| TECHTRAN LIMITED | Sekretär | Leeds Innovation Centre 103 Clarendon Road LS2 9DF Leeds West Yorkshire | 101761630001 | |||||||||||
| BARKER, Michael Denis | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 160393640002 | |||||||||
| COCKE, David Claiborne | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 279282120001 | |||||||||
| COULDWELL, Steven Ashley | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 240376920001 | |||||||||
| COVE, Jonathan Howard, Doctor | Geschäftsführer | 8 Moorlands Westwood Drive LS29 9QZ Ilkley West Yorkshire | United Kingdom | British | 91894120001 | |||||||||
| DEVLIN, Paul John | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 113889280002 | |||||||||
| DOYLE, Christina, Professor | Geschäftsführer | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | England | British | 87254760001 | |||||||||
| FISHER, John, Professor | Geschäftsführer | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | England | British | 60523680001 | |||||||||
| GLENN, Jonathan Martin | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United Kingdom | British | 148251560003 | |||||||||
| INGHAM, Eileen, Professor | Geschäftsführer | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | United Kingdom | British | 52281140001 | |||||||||
| JEFFERSON, Ian David | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 80245080002 | |||||||||
| JONES, Gareth Hywel | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 252371380001 | |||||||||
| LEE, Daniel Ray | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | United States | American | 277099400001 | |||||||||
| MILLER, Alan Jonathan Richard | Geschäftsführer | Lotherton Way Garforth LS25 2GY Leeds Unit 3, Phoenix Court England | England | British | 127433380001 | |||||||||
| ODELL, Antony Ruben | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 152306920001 | |||||||||
| SAMUEL, John Andrew Walter | Geschäftsführer | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | England | British | 130457350001 | |||||||||
| STEVENSON, Alexander James | Geschäftsführer | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire | United Kingdom | British | 152307480001 | |||||||||
| IP2IPO SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Innovation Way Heslington YO10 5NY York The Biocentre North Yorkshire United Kingdom |
| 122951520001 | ||||||||||
| TECHTRAN LIMITED | Geschäftsführer | Leeds Innovation Centre 103 Clarendon Road LS2 9DF Leeds West Yorkshire | 101761630001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TISSUE REGENIX LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissue Regenix Group Plc | 06. Apr. 2016 | Astley Way, Astley Lane Industrial Estate Swillington LS26 8XT Leeds Unit 1 And 2 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0