PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 06594872 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?
- Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen (28490) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Holroyd Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| J & S REMANUFACTURE LIMITED | 16. Mai 2008 | 16. Mai 2008 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 10 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||
Ernennung von Mr Colin Steven Carr als Direktor am 29. Juli 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Antony James Bannan als Geschäftsführer am 29. Juli 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 11 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 16 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Beendigung der Bestellung von Kai Wu als Geschäftsführer am 27. Sept. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Deyong Liu als Direktor am 11. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Quan Yang als Direktor am 11. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Shaobo Qin als Geschäftsführer am 11. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 3 Seiten | AA | ||
Notification of Precision Technologies Group (Ptg) Ltd as a person with significant control on 01. Jan. 2019 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Ernennung von Mr Shaobo Qin als Direktor am 16. Aug. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Wenguang Sun als Geschäftsführer am 16. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 30 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEARY, Laurence John | Sekretär | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire United Kingdom | 179251490001 | |||||||
| CARR, Colin Steven | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire | England | British | 196629940001 | |||||
| LIU, Deyong | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire | China | Chinese | 268920610001 | |||||
| NEARY, Laurence John | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire | England | British | 184437000001 | |||||
| YANG, Quan | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire | China | Chinese | 268918160001 | |||||
| EMERY, Ian Robert | Sekretär | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire United Kingdom | 165425580001 | |||||||
| MAHER, Adam Antony | Sekretär | 33 Portland Drive LE10 1SE Hinckley Leicestershire | British | 122777430001 | ||||||
| BANNAN, Antony James, Dr | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire United Kingdom | England | British | 136002800004 | |||||
| CHEN, Yu | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire United Kingdom | China | Chinese | 179282710001 | |||||
| FRANCKEL, Mark Bernard | Geschäftsführer | Alexandra Road Grappenhall WA4 2EL Warrington 8 Cheshire | United Kingdom | British | 137556900001 | |||||
| GRIFFITHS, William Carl | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Ptg Lancashire England | United Kingdom | British | 163069470001 | |||||
| HENG, Dechao | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire | China | Chinese | 200787340001 | |||||
| LIANGLIANG, Tang | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire | China | Chinese | 211858770001 | |||||
| LIU, Chunmei | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire United Kingdom | United Kingdom | Chinese | 152317680001 | |||||
| LORD, Stephen John William | Geschäftsführer | Southernhay Road LE2 3TP Leicester 83 Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 134469010001 | |||||
| MACDONALD, Roderick | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire United Kingdom | Great Britain | British | 166787420001 | |||||
| MAHER, Adam Antony | Geschäftsführer | 33 Portland Drive LE10 1SE Hinckley Leicestershire | England | British | 122777430001 | |||||
| QIN, Shaobo | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire | China | Chinese | 251627470001 | |||||
| SUN, Wenguang | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire | China | Chinese | 229241960001 | |||||
| SUN, Xilin | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire United Kingdom | China | Chinese | 179282850001 | |||||
| WU, Kai | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire | China | Chinese | 229242290001 | |||||
| YUAN, Bin | Geschäftsführer | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd Lancashire United Kingdom | England | Chinese | 152248920001 | |||||
| INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Geschäftsführer | Colmore Row B3 2AS Birmingham 55 | 130465940001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision Technologies Group (Ptg) Ltd | 01. Jan. 2019 | Harbour Lane North Milnrow OL16 3LQ Rochdale Holroyd England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 12. Okt. 2010 Geliefert am 13. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security over cash deposit | Erstellt am 16. Jan. 2009 Geliefert am 21. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The chargor charged the deposit by way of fixed charge all amounts deposited to the credit of the accounts numbered 400515 69286729, 400515 69288206, 400520 81665146. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juni 2008 Geliefert am 04. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0