PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED

PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06594872
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?

    • Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen (28490) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Holroyd Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    J & S REMANUFACTURE LIMITED16. Mai 200816. Mai 2008

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Ernennung von Mr Colin Steven Carr als Direktor am 29. Juli 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Antony James Bannan als Geschäftsführer am 29. Juli 2022

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    11 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Kai Wu als Geschäftsführer am 27. Sept. 2020

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Deyong Liu als Direktor am 11. Okt. 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Quan Yang als Direktor am 11. Okt. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Shaobo Qin als Geschäftsführer am 11. Okt. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    3 SeitenAA

    Notification of Precision Technologies Group (Ptg) Ltd as a person with significant control on 01. Jan. 2019

    2 SeitenPSC02

    Ernennung von Mr Shaobo Qin als Direktor am 16. Aug. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Wenguang Sun als Geschäftsführer am 16. Aug. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    30 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NEARY, Laurence John
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    Sekretär
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    179251490001
    CARR, Colin Steven
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    EnglandBritish196629940001
    LIU, Deyong
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    ChinaChinese268920610001
    NEARY, Laurence John
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    EnglandBritish184437000001
    YANG, Quan
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    ChinaChinese268918160001
    EMERY, Ian Robert
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    Sekretär
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    165425580001
    MAHER, Adam Antony
    33 Portland Drive
    LE10 1SE Hinckley
    Leicestershire
    Sekretär
    33 Portland Drive
    LE10 1SE Hinckley
    Leicestershire
    British122777430001
    BANNAN, Antony James, Dr
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish136002800004
    CHEN, Yu
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    ChinaChinese179282710001
    FRANCKEL, Mark Bernard
    Alexandra Road
    Grappenhall
    WA4 2EL Warrington
    8
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Alexandra Road
    Grappenhall
    WA4 2EL Warrington
    8
    Cheshire
    United KingdomBritish137556900001
    GRIFFITHS, William Carl
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Ptg
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Ptg
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish163069470001
    HENG, Dechao
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    ChinaChinese200787340001
    LIANGLIANG, Tang
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    ChinaChinese211858770001
    LIU, Chunmei
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomChinese152317680001
    LORD, Stephen John William
    Southernhay Road
    LE2 3TP Leicester
    83
    Leicestershire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Southernhay Road
    LE2 3TP Leicester
    83
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish134469010001
    MACDONALD, Roderick
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    Great BritainBritish166787420001
    MAHER, Adam Antony
    33 Portland Drive
    LE10 1SE Hinckley
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    33 Portland Drive
    LE10 1SE Hinckley
    Leicestershire
    EnglandBritish122777430001
    QIN, Shaobo
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    ChinaChinese251627470001
    SUN, Wenguang
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    ChinaChinese229241960001
    SUN, Xilin
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    ChinaChinese179282850001
    WU, Kai
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    ChinaChinese229242290001
    YUAN, Bin
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandChinese152248920001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    55
    Geschäftsführer
    Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    55
    130465940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Precision Technologies Group (Ptg) Ltd
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    England
    01. Jan. 2019
    Harbour Lane North
    Milnrow
    OL16 3LQ Rochdale
    Holroyd
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandNa
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortUk
    Registrierungsnummer07724976
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat PTG HEAVY INDUSTRIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 12. Okt. 2010
    Geliefert am 13. Okt. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security over cash deposit
    Erstellt am 16. Jan. 2009
    Geliefert am 21. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The chargor charged the deposit by way of fixed charge all amounts deposited to the credit of the accounts numbered 400515 69286729, 400515 69288206, 400520 81665146.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2009
    • 22. Jan. 2009
    • 29. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2008
    Geliefert am 04. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transaktionen
    • 04. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0