PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | NI019968 |
Gerichtsbarkeit | Nordirland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Aisling House 50 Stranmillis Embankment BT9 5FL Belfast Northern Ireland |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ARCON MINERALS AND PETROLEUM (NORTHERN IRELAND) LIMITED | 18. März 1993 | 18. März 1993 |
CONROY PETROLEUM (NORTHERN IRELAND) LIMITED | 27. Nov. 1986 | 27. Nov. 1986 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Angus Murray Mccoss als Geschäftsführer am 20. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Angus Mccoss als Direktor am 06. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Patrick Plunkett als Direktor am 06. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Simon Brett als Sekretär am 06. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tony O'reilly als Geschäftsführer am 06. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tony O'reilly als Sekretär am 06. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Geo.L. Maclaine Solicitors Imperial Buildings 72 High Street Belfast BT1 2BE zum C/O Aisling House 50 Stranmillis Embankment Belfast BT9 5FL am 28. Nov. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Tony O'reilly als Sekretär am 16. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Criona Ryan als Sekretär am 16. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John O'sullivan als Geschäftsführer am 06. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 10 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 20 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Criona Ryan als Sekretär am 29. Feb. 2016 | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Simon Brett als Direktor am 29. Feb. 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Gerald Graham als Sekretär am 29. Feb. 2016 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRETT, Simon | Sekretär | Stranmillis Embankment BT9 5FL Belfast C/O Aisling House 50 Northern Ireland | 265481610001 | |||||||
BRETT, Simon | Geschäftsführer | Airfield Park Donnybrook Dublin Airfield House Do4 Cp49 Ireland | Ireland | Irish | Accountant | 206531150001 | ||||
PLUNKETT, Patrick Joseph | Geschäftsführer | Stranmillis Embankment BT9 5FL Belfast C/O Aisling House 50 Northern Ireland | Ireland | Irish | Director | 180198160002 | ||||
GRAHAM, Michael Gerald | Sekretär | 54 Taney Road Dundrum Dublin 14 | Irish | 144296630001 | ||||||
O'REILLY, Tony | Sekretär | Triq Santa Clara Baharic Caghaq Mariner Malta | 261521290001 | |||||||
RYAN, Criona | Sekretär | Airfield Park Donnybrook Dublin Airfield House Do4 Cp49 Ireland | 206456990001 | |||||||
BLANKENBURGRS, Andris | Geschäftsführer | 51 Pembroke Lane Ballsbridge Dublin 4 | British | Engineer | 144296590001 | |||||
CARROLL, Stephen Gerard | Geschäftsführer | 79 Knocknashee Goatsto9wn Dublin Ireland | Irish | Chartered Accountant | 74798710001 | |||||
CASTON, Vivian, Dr | Geschäftsführer | Hilltop Croit E Quill Laxey Isle Of Man | British | Geologist | 144296570001 | |||||
GRAHAM, Michael Gerald | Geschäftsführer | 54 Taney Road Dundrum Dublin 14 Ireland | Ireland | Irish | Chartered Secretary | 144296630001 | ||||
HILLERY, Brian, Dr | Geschäftsführer | Ingleside 36 Orwell Park Raghgar Dublin 6 | Irish | University Lecturer | 144296600001 | |||||
KIDNEY, William Peter | Geschäftsführer | 21 Palmerston Gardens Rathmines Dublin 6 | Ireland | Irish | Chartered Accountant | 45172690002 | ||||
MCCOSS, Angus Murray, Dr | Geschäftsführer | Stranmillis Embankment BT9 5FL Belfast C/O Aisling House 50 Northern Ireland | England | British | Director | 265480090001 | ||||
O'QUIGLEY, Philip | Geschäftsführer | 6 Blackheath Gardens Clontarf Dublin 3 Ireland | Ireland | Irish | Chartered Accountant | 134241380002 | ||||
O'REILLY, Anthony | Geschäftsführer | 26 Leeson Park Dublin | Irish | Company Executive | 144296550001 | |||||
O'REILLY, Tony | Geschäftsführer | Airfield Park Donnybrook Airfield House Dublin 4 Ireland | Malta | Irish | Company Executive | 169256470001 | ||||
O'SULLIVAN, John | Geschäftsführer | Airfield Park Donnybrook Airfield House Dublin 4 Ireland | Ireland | Irish | Company Executive | 169256220001 | ||||
REIHILL, Shane Anthony | Geschäftsführer | Kingstown Penthouse Killiney Hill Park Killiney Co Dublin | Irish | Business Executive | 144296580001 | |||||
TRACY, Philip Oliver James | Geschäftsführer | 5 Inverleith Avenue South Edinburgh EH3 5QA Scotland | United Kingdom | British | Petroleum Engineer | 778900001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Providence Resources Plc | 14. Sept. 2016 | Airfield Park Donnybrook Airfield House D04 Cp49 Ireland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Erstellt am 05. Okt. 2009 Geliefert am 21. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben As collateral security for all of the secured liabilities, the debtor hereby grants to secured party a security interest in, a general lien upon... See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 05. Okt. 2009 Geliefert am 21. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1. a first fixed charge with full title guarantee over all of the company's rights to and title and interest from time to time in, to the extent not effectively assigned under paragraph 2 below, the insurance policies and insurance proceeds and, in each case, together with all related rights related thereto...see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 05. Okt. 2009 Geliefert am 21. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1. a first floating charge over all of the company's rights to and title and interest from time to time in the whole of it's property, assets, rights and revenues, whatsoever and wheresoever, at the date of execution of the security agreement and at any time thereafter...see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Apr. 2006 Geliefert am 03. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben Debenture - all monies. 1. fixed charges. 1. the company, as security for the payment of the indebtedness, charges in favour of the chargee with full title guarantee (or in the case of NI charged property as beneficial owner) the following assets, both present and future, from time to time owned by it or in which it has an interest:. (I)(a) by way of first legal mortgage all freehold and leasehold borrowing base properties wherever situated together with all buildings and fixtures ( including trade fixtures) at any time thereon;. (I)(b) hereby grant and demises unto the chargee as to so much of the borrowing base...... | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 04. Aug. 1998 Geliefert am 17. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben Deed of collateral debenture. All the company's undertaking and assets wheresoever and whatsoever both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill. Doc 52 on the main file refers. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 10. Sept. 1997 Geliefert am 23. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Floating charge debenture a floating charge over the companys undertaking and all its assets and rights whatsoever and wheresoever present and future including building and trade fixtures fixed plant and machinery but so that the company shall not without the prior consent in writing of the bank create or permit to subsist any mortgage, charge, lien pledge or other security over the assets or any part of them ranking in priority to or pari passu with this floating charge or part with, sell or dispose of the whole or (except in the ordinary course of the companys business and for the purpose of carrying on the same) any part of the assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 17. Nov. 1995 Geliefert am 28. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Deed of collateral debenture all the company's undertaking and assets whereosever and whatsoever both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill the collateral debenture provides that if icc bank PLC issues to the company a notice in writing that an event of default as set out in the collateral debenture has occurred the charge created by the collateral debenture over the assets hereto described (with the exception of the book debts which are specifically excluded) shall crystallise and become a fixed and specific charge over the said assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 04. Juni 1993 Geliefert am 08. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Legal charge firstly: all the companies right title and interest as licencee in and under the terms of the licence (as defined in the charge). Secondly: all book and other debts rev- enues and claims which both present and future (including things in actions which give rise or may give rise to a debt or claim) due or owing or which may become due or owing to the company or purchased or otherwise acquired by the company or by the operator (as defined in the charge) on its behalf and which relate to the company's entitlement to its percentage interest (as defined in the charge) and all petroleum (as de- fined in the charge) available to be taken in kind and disposed of by it pursuant to the terms of the operating agreement (as defined in the charge) and all monies received or receivable by the company under any policy of insurance taken out in respect of actual or poten- tial liabilities under the licence and operating agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage or charge | Erstellt am 18. Juni 1992 Geliefert am 07. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 0 | |
Kurze Angaben All monies. Collateral debenture all the company's undertakings and assets wheresoever and whatsoever both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill. The collateral debenture provides that if industrial credit corporation PLC issues to the company a notice in writing that an event of default as set out in the collateral debenture has occurred the charge created by the collateral debenture over the assets described in column 4 hereof (with the exception of the book debts which are specifically excluded) shall crystallise and become a fixed and specific charge over the said assets. Note: the debenture contains a covenant by the company not to create any mortgage charge or lien ranking pari passu with or in priority thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0