PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED

PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer NI019968
    GerichtsbarkeitNordirland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Aisling House 50
    Stranmillis Embankment
    BT9 5FL Belfast
    Northern Ireland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ARCON MINERALS AND PETROLEUM (NORTHERN IRELAND) LIMITED18. März 199318. März 1993
    CONROY PETROLEUM (NORTHERN IRELAND) LIMITED27. Nov. 198627. Nov. 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von Angus Murray Mccoss als Geschäftsführer am 20. Juli 2020

    1 SeitenTM01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Ernennung von Angus Mccoss als Direktor am 06. Dez. 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Patrick Plunkett als Direktor am 06. Dez. 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Simon Brett als Sekretär am 06. Dez. 2019

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Tony O'reilly als Geschäftsführer am 06. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Tony O'reilly als Sekretär am 06. Dez. 2019

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Geo.L. Maclaine Solicitors Imperial Buildings 72 High Street Belfast BT1 2BE zum C/O Aisling House 50 Stranmillis Embankment Belfast BT9 5FL am 28. Nov. 2019

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    19 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Tony O'reilly als Sekretär am 16. Aug. 2019

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Criona Ryan als Sekretär am 16. Aug. 2019

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von John O'sullivan als Geschäftsführer am 06. Aug. 2019

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Sept. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    10 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    20 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 27. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Criona Ryan als Sekretär am 29. Feb. 2016

    3 SeitenAP03

    Ernennung von Simon Brett als Direktor am 29. Feb. 2016

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Michael Gerald Graham als Sekretär am 29. Feb. 2016

    2 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRETT, Simon
    Stranmillis Embankment
    BT9 5FL Belfast
    C/O Aisling House 50
    Northern Ireland
    Sekretär
    Stranmillis Embankment
    BT9 5FL Belfast
    C/O Aisling House 50
    Northern Ireland
    265481610001
    BRETT, Simon
    Airfield Park
    Donnybrook
    Dublin
    Airfield House
    Do4 Cp49
    Ireland
    Geschäftsführer
    Airfield Park
    Donnybrook
    Dublin
    Airfield House
    Do4 Cp49
    Ireland
    IrelandIrishAccountant206531150001
    PLUNKETT, Patrick Joseph
    Stranmillis Embankment
    BT9 5FL Belfast
    C/O Aisling House 50
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    Stranmillis Embankment
    BT9 5FL Belfast
    C/O Aisling House 50
    Northern Ireland
    IrelandIrishDirector180198160002
    GRAHAM, Michael Gerald
    54 Taney Road
    Dundrum
    Dublin 14
    Sekretär
    54 Taney Road
    Dundrum
    Dublin 14
    Irish144296630001
    O'REILLY, Tony
    Triq Santa Clara
    Baharic Caghaq
    Mariner
    Malta
    Sekretär
    Triq Santa Clara
    Baharic Caghaq
    Mariner
    Malta
    261521290001
    RYAN, Criona
    Airfield Park
    Donnybrook
    Dublin
    Airfield House
    Do4 Cp49
    Ireland
    Sekretär
    Airfield Park
    Donnybrook
    Dublin
    Airfield House
    Do4 Cp49
    Ireland
    206456990001
    BLANKENBURGRS, Andris
    51 Pembroke Lane
    Ballsbridge
    Dublin 4
    Geschäftsführer
    51 Pembroke Lane
    Ballsbridge
    Dublin 4
    BritishEngineer144296590001
    CARROLL, Stephen Gerard
    79 Knocknashee
    Goatsto9wn
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    79 Knocknashee
    Goatsto9wn
    Dublin
    Ireland
    IrishChartered Accountant74798710001
    CASTON, Vivian, Dr
    Hilltop
    Croit E Quill
    Laxey
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Hilltop
    Croit E Quill
    Laxey
    Isle Of Man
    BritishGeologist144296570001
    GRAHAM, Michael Gerald
    54 Taney Road
    Dundrum
    Dublin 14
    Ireland
    Geschäftsführer
    54 Taney Road
    Dundrum
    Dublin 14
    Ireland
    IrelandIrishChartered Secretary144296630001
    HILLERY, Brian, Dr
    Ingleside
    36 Orwell Park
    Raghgar
    Dublin 6
    Geschäftsführer
    Ingleside
    36 Orwell Park
    Raghgar
    Dublin 6
    IrishUniversity Lecturer144296600001
    KIDNEY, William Peter
    21 Palmerston Gardens
    Rathmines
    Dublin 6
    Geschäftsführer
    21 Palmerston Gardens
    Rathmines
    Dublin 6
    IrelandIrishChartered Accountant45172690002
    MCCOSS, Angus Murray, Dr
    Stranmillis Embankment
    BT9 5FL Belfast
    C/O Aisling House 50
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    Stranmillis Embankment
    BT9 5FL Belfast
    C/O Aisling House 50
    Northern Ireland
    EnglandBritishDirector265480090001
    O'QUIGLEY, Philip
    6 Blackheath Gardens
    Clontarf
    Dublin 3
    Ireland
    Geschäftsführer
    6 Blackheath Gardens
    Clontarf
    Dublin 3
    Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant134241380002
    O'REILLY, Anthony
    26 Leeson Park
    Dublin
    Geschäftsführer
    26 Leeson Park
    Dublin
    IrishCompany Executive144296550001
    O'REILLY, Tony
    Airfield Park
    Donnybrook
    Airfield House
    Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    Airfield Park
    Donnybrook
    Airfield House
    Dublin 4
    Ireland
    MaltaIrishCompany Executive169256470001
    O'SULLIVAN, John
    Airfield Park
    Donnybrook
    Airfield House
    Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    Airfield Park
    Donnybrook
    Airfield House
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrishCompany Executive169256220001
    REIHILL, Shane Anthony
    Kingstown Penthouse
    Killiney Hill Park
    Killiney
    Co Dublin
    Geschäftsführer
    Kingstown Penthouse
    Killiney Hill Park
    Killiney
    Co Dublin
    IrishBusiness Executive144296580001
    TRACY, Philip Oliver James
    5 Inverleith Avenue South
    Edinburgh
    EH3 5QA Scotland
    Geschäftsführer
    5 Inverleith Avenue South
    Edinburgh
    EH3 5QA Scotland
    United KingdomBritishPetroleum Engineer778900001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Providence Resources Plc
    Airfield Park
    Donnybrook
    Airfield House
    D04 Cp49
    Ireland
    14. Sept. 2016
    Airfield Park
    Donnybrook
    Airfield House
    D04 Cp49
    Ireland
    Nein
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandIreland
    RechtsgrundlageIrish Law
    RegistrierungsortCompanies Registration Office Ireland
    Registrierungsnummer268662
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat PROVIDENCE RESOURCES (N.I.) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 05. Okt. 2009
    Geliefert am 21. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    As collateral security for all of the secured liabilities, the debtor hereby grants to secured party a security interest in, a general lien upon... See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bnp Paribas
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 05. Okt. 2009
    Geliefert am 21. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1. a first fixed charge with full title guarantee over all of the company's rights to and title and interest from time to time in, to the extent not effectively assigned under paragraph 2 below, the insurance policies and insurance proceeds and, in each case, together with all related rights related thereto...see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bnp Paribas
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 05. Okt. 2009
    Geliefert am 21. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1. a first floating charge over all of the company's rights to and title and interest from time to time in the whole of it's property, assets, rights and revenues, whatsoever and wheresoever, at the date of execution of the security agreement and at any time thereafter...see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bnp Paribas
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2006
    Geliefert am 03. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    Debenture - all monies. 1. fixed charges. 1. the company, as security for the payment of the indebtedness, charges in favour of the chargee with full title guarantee (or in the case of NI charged property as beneficial owner) the following assets, both present and future, from time to time owned by it or in which it has an interest:. (I)(a) by way of first legal mortgage all freehold and leasehold borrowing base properties wherever situated together with all buildings and fixtures ( including trade fixtures) at any time thereon;. (I)(b) hereby grant and demises unto the chargee as to so much of the borrowing base......
    Berechtigte Personen
    • Macquarie Bank Limited
    Transaktionen
    • 03. Mai 2006Registrierung einer Belastung (402 NI)
    • 11. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 04. Aug. 1998
    Geliefert am 17. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    Deed of collateral debenture. All the company's undertaking and assets wheresoever and whatsoever both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill. Doc 52 on the main file refers.
    Berechtigte Personen
    • Icc Bank PLC.
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 10. Sept. 1997
    Geliefert am 23. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Floating charge debenture a floating charge over the companys undertaking and all its assets and rights whatsoever and wheresoever present and future including building and trade fixtures fixed plant and machinery but so that the company shall not without the prior consent in writing of the bank create or permit to subsist any mortgage, charge, lien pledge or other security over the assets or any part of them ranking in priority to or pari passu with this floating charge or part with, sell or dispose of the whole or (except in the ordinary course of the companys business and for the purpose of carrying on the same) any part of the assets.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 17. Nov. 1995
    Geliefert am 28. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Deed of collateral debenture all the company's undertaking and assets whereosever and whatsoever both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill the collateral debenture provides that if icc bank PLC issues to the company a notice in writing that an event of default as set out in the collateral debenture has occurred the charge created by the collateral debenture over the assets hereto described (with the exception of the book debts which are specifically excluded) shall crystallise and become a fixed and specific charge over the said assets.
    Berechtigte Personen
    • Icc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (411A NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 04. Juni 1993
    Geliefert am 08. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Legal charge firstly: all the companies right title and interest as licencee in and under the terms of the licence (as defined in the charge). Secondly: all book and other debts rev- enues and claims which both present and future (including things in actions which give rise or may give rise to a debt or claim) due or owing or which may become due or owing to the company or purchased or otherwise acquired by the company or by the operator (as defined in the charge) on its behalf and which relate to the company's entitlement to its percentage interest (as defined in the charge) and all petroleum (as de- fined in the charge) available to be taken in kind and disposed of by it pursuant to the terms of the operating agreement (as defined in the charge) and all monies received or receivable by the company under any policy of insurance taken out in respect of actual or poten- tial liabilities under the licence and operating agreement.
    Berechtigte Personen
    • Ansbacher Bankers
    Transaktionen
    • 08. Juni 1993Registrierung einer Belastung (402 NI)
    Mortgage or charge
    Erstellt am 18. Juni 1992
    Geliefert am 07. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    0
    Kurze Angaben
    All monies. Collateral debenture all the company's undertakings and assets wheresoever and whatsoever both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill. The collateral debenture provides that if industrial credit corporation PLC issues to the company a notice in writing that an event of default as set out in the collateral debenture has occurred the charge created by the collateral debenture over the assets described in column 4 hereof (with the exception of the book debts which are specifically excluded) shall crystallise and become a fixed and specific charge over the said assets. Note: the debenture contains a covenant by the company not to create any mortgage charge or lien ranking pari passu with or in priority thereto.
    Berechtigte Personen
    • Industrial Credit
    Transaktionen
    • 07. Juli 1992

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0