ANGELS CARE SERVICES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ANGELS CARE SERVICES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | NI041623 |
Gerichtsbarkeit | Nordirland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ANGELS CARE SERVICES LIMITED?
- Sonstige soziale Arbeit ohne Unterbringung n.n.g. (88990) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich ANGELS CARE SERVICES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 337 Castlereagh Road BT5 6AB Belfast Northern Ireland |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANGELS CARE SERVICES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ANGELS CARE SERVICES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Ernennung von Ms Lynette Gillian Krige als Direktor am 17. Mai 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Thorburn am 01. März 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 9B First Floor Silverwood Business Park Silverwood Road Craigavon Northern Ireland BT66 6SY zum 337 Castlereagh Road Belfast BT5 6AB am 23. März 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Julianne Baker als Geschäftsführer am 01. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Nick Goodban als Direktor am 01. März 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr James Thorburn als Direktor am 01. März 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ford David Porter als Geschäftsführer am 01. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Vellacott als Geschäftsführer am 01. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2019 | 12 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. März 2018 | 6 Seiten | AA | ||
Notification of Mc Care Holdings Limited as a person with significant control on 17. Dez. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Mihomecare Limited as a person with significant control on 17. Dez. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Notification of Mihomecare Limited as a person with significant control on 18. Okt. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Enara Finance Limited as a person with significant control on 17. Okt. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Narinder Singh als Geschäftsführer am 12. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Jonathan Vellacott als Direktor am 12. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. März 2017 | 8 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ANGELS CARE SERVICES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODBAN, Nicholas James | Geschäftsführer | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | England | British | Company Director | 274517200003 | ||||||||
KRIGE, Lynette Gillian | Geschäftsführer | Castlereagh Road BT5 6AB Belfast 337 Northern Ireland | England | British | Chief Financial Officer | 283338100002 | ||||||||
THORBURN-MUIRHEAD, James | Geschäftsführer | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | England | British | Company Director | 135453260002 | ||||||||
JACKSON, David | Sekretär | Silverwood Business Park Silverwood Road BT66 6SY Craigavon Unit 9b First Floor Northern Ireland | 169335370001 | |||||||||||
WILSON, Margo Matthews | Sekretär | 9-11 Low Road Larne BT40 3RD | 145084390001 | |||||||||||
MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Silverwood Business Park Silverwood Road BT66 6SY Craigavon Unit 9b, First Floor Northern Ireland |
| 173229170001 | ||||||||||
BAKER, Julianne | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | Director | 192429900001 | ||||||||
BOOTY, Stephen Martin | Geschäftsführer | c/o C/O Elliot Duffy Garrett 34 Upper Queen Street BT1 6FD Belfast Royston House Northern Ireland | England | British | Director | 147928010001 | ||||||||
DOBELL, Colin Andrew | Geschäftsführer | Silverwood Business Park Silverwood Road BT66 6SY Craigavon Unit 9b First Floor Northern Ireland | England | British | Managing Director | 63959230003 | ||||||||
DUN, Andrew Frederick | Geschäftsführer | Silverwood Business Park Silverwood Road BT66 6SY Craigavon Unit 9b First Floor Northern Ireland | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 85855780002 | ||||||||
FELTON, Wayne Harold | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | Director | 173205650001 | ||||||||
FLANAGAN, Jeffrey Paul | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | Director | 50878080003 | ||||||||
GRAY, Susan Annette | Geschäftsführer | c/o C/O Elliot Duffy Garrett 34 Upper Queen Street BT1 6FD Belfast Royston House Northern Ireland | United Kingdom | British | Managing Director | 55858850004 | ||||||||
HARLAND, David Nicholas | Geschäftsführer | Silverwood Business Park Silverwood Road BT66 6SY Craigavon Unit 9b First Floor Northern Ireland | England | British | Accountant | 173208950001 | ||||||||
JACKSON, David | Geschäftsführer | c/o C/O Elliot Duffy Garrett 34 Upper Queen Street BT1 6FD Belfast Royston House Northern Ireland | United Kingdom | British | Finance Director | 280628560001 | ||||||||
JARMAIN, Alison | Geschäftsführer | 1 Sandy Lane Ystradowen Nr Cowbridge Vale Of Glamorgan | British | Care Services | 145084420001 | |||||||||
JARMAIN, Gary | Geschäftsführer | 1 Sandy Lane Ystradowen Nr Cowbridge Vale Of Glamorgan | British | Care Services | 145084430001 | |||||||||
MANNAN, Rohit | Geschäftsführer | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | Director | 181783660001 | ||||||||
PALMER, Robert Desmond | Geschäftsführer | 31 Kilmaine Road Bangor BT19 6DT Co Down | Northern Ireland | British | Formation Agent | 143255820001 | ||||||||
PORTER, Ford David | Geschäftsführer | Hawksworth Road Central Park TF2 9TU Telford 1 Shropshire United Kingdom | England | British,American | Investment Manager | 235635120001 | ||||||||
SINGH, Narinder | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | England | British | Managing Director | 193406470001 | ||||||||
STAUNTON, Martin | Geschäftsführer | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | Director | 192431160001 | ||||||||
STIRLAND, Patrick Walter | Geschäftsführer | Silverwood Business Park Silverwood Road BT66 6SY Craigavon Unit 9b First Floor Northern Ireland | United Kingdom | British | Director | 69756530007 | ||||||||
VELLACOTT, Jonathan James | Geschäftsführer | Silverwood Business Park Silverwood Road BT66 6SY Craigavon Unit 9b First Floor Northern Ireland | England | British | Executive Chairman | 250741990001 | ||||||||
WILSON, Margo Matthews | Geschäftsführer | Low Road Islandmagee BT40 3RD Larne 9-11 Co Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | Director | 145604720001 | ||||||||
WILSON, Norrie | Geschäftsführer | 10 Chapman Court Newport NP20 4JH South Wales | Wales | British | Recruitment Consultant Engin | 175461250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ANGELS CARE SERVICES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mc Care Holdings Limited | 17. Dez. 2018 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YB Birmingham 1310 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mihomecare Limited | 18. Okt. 2018 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YB Birmingham 1310 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Enara Finance Limited | 06. Apr. 2016 | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ANGELS CARE SERVICES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 04. Mai 2012 Geliefert am 11. Mai 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Mai 2011 Geliefert am 23. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery...see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0