EARTHSHARE LTD.

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEARTHSHARE LTD.
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer SC149109
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EARTHSHARE LTD.?

    • (0111) /
    • (0112) /

    Wo befindet sich EARTHSHARE LTD.?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ty Crwn East Grange
    Kinloss
    IV36 2UD Forres
    Moray
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EARTHSHARE LTD.?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für EARTHSHARE LTD.?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 29 Pringle Road Elgin Moray IV30 4HN am 22. Sept. 2011

    4 SeitenAD01

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    5 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2010

    5 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Nic Molnar Kininvie, 3 Albert Street Forres Morayshire IV36 1PR Scotland am 13. Aug. 2010

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Christian Molnar als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Jonathan Dawson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Raymont als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Apr. 2010

    Kapitalaufstellung am 21. Apr. 2010

    • Kapital: GBP 120
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Christopher Raymont am 17. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Christian Nicholas Molnar am 17. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Duerten Inge Lau am 17. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Ms Claire Sandra Wirsig als Direktor

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 9 Church Terrace Rafford Forres Moray IV36 2RJ Scotland am 19. Feb. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2009

    6 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von EARTHSHARE LTD.?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAWSON, Jonathan
    East Grange
    Kinloss
    IV36 2UD Forres
    Ty Crwn
    Moray
    Geschäftsführer
    East Grange
    Kinloss
    IV36 2UD Forres
    Ty Crwn
    Moray
    United KingdomBritish150986620001
    LAU, Duerten Inge
    The Park Findhorn
    IV36 3TZ Forres
    223
    Moray
    Scotland
    Geschäftsführer
    The Park Findhorn
    IV36 3TZ Forres
    223
    Moray
    Scotland
    ScotlandGerman137661140001
    WIRSIG, Claire Sandra
    East Grange
    Kinloss
    IV36 2UD Forres
    Ty Crwn
    Moray
    Geschäftsführer
    East Grange
    Kinloss
    IV36 2UD Forres
    Ty Crwn
    Moray
    ScotlandUnited States149103440001
    BOCHEL, Pam Mhairi
    Society Street
    IV12 4NL Nairn
    65
    Nairnshire
    Sekretär
    Society Street
    IV12 4NL Nairn
    65
    Nairnshire
    British140213460001
    EMMERSON, Kim Andree
    Findhorn Foundation
    The Park
    IV36 OTZ Forres
    Sekretär
    Findhorn Foundation
    The Park
    IV36 OTZ Forres
    British42331540001
    LOWE, John Chorlton
    29 Conicavel
    Darnaway
    IV36 2TU Forres
    Morayshire
    Sekretär
    29 Conicavel
    Darnaway
    IV36 2TU Forres
    Morayshire
    British59075810002
    MACPHERSON-STEWART, Johnstone Findlay
    Greeshop House
    Forres
    IV36 2SN Moray
    Sekretär
    Greeshop House
    Forres
    IV36 2SN Moray
    Scottish65513900002
    REID, Brian
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    British900007130001
    ROLFE, Dawn Ann
    Greeshop House
    IV36 2SN Forres
    Moray
    Sekretär
    Greeshop House
    IV36 2SN Forres
    Moray
    British65513840002
    WEAVER, Jane Hilary
    The Hillock
    125 Findhorn
    IV36 0YJ Forres
    Moray
    Sekretär
    The Hillock
    125 Findhorn
    IV36 0YJ Forres
    Moray
    British52904090002
    ADAM, Julie
    East View
    IV36 2TF Dyke
    Moray
    Iv36 2tf
    Geschäftsführer
    East View
    IV36 2TF Dyke
    Moray
    Iv36 2tf
    British101746430002
    AIKMAN, Andrew Richard
    13 Whiteinch Small Holdings
    IV36 0TS Forres
    Morayshire
    Geschäftsführer
    13 Whiteinch Small Holdings
    IV36 0TS Forres
    Morayshire
    British37974230002
    BAROUCH, Fabien
    Findhorn Foundation
    Findhorn
    IV36 0TZ Forres
    Morayshire
    Geschäftsführer
    Findhorn Foundation
    Findhorn
    IV36 0TZ Forres
    Morayshire
    French39162040001
    BELL, David Allan
    46 Reynolds Crescent
    IV30 6TP Elgin
    Morayshire
    Geschäftsführer
    46 Reynolds Crescent
    IV30 6TP Elgin
    Morayshire
    British109500720001
    BOCHEL, Pam Mhairi
    Society Street
    IV12 4NL Nairn
    65
    Nairnshire
    Geschäftsführer
    Society Street
    IV12 4NL Nairn
    65
    Nairnshire
    United KingdomBritish140213460001
    COOPER, Nicholas Jay
    Broomhill Cottage
    IV36 2RH Rufford
    Morayshire
    Geschäftsführer
    Broomhill Cottage
    IV36 2RH Rufford
    Morayshire
    British111009990001
    HAFNER, Manfred
    1 Whiteinch Small Holdings
    IV36 0TS Forres
    Morayshire
    Geschäftsführer
    1 Whiteinch Small Holdings
    IV36 0TS Forres
    Morayshire
    British37974210001
    HAMM, Michael Richard
    4 Whiteinch Kinloss
    IV36 0TS Forres
    Moray
    Geschäftsführer
    4 Whiteinch Kinloss
    IV36 0TS Forres
    Moray
    American52904110001
    HENDRY, Vanessa
    Homelea
    Dyke
    IV36 0TF Forres
    Moray
    Geschäftsführer
    Homelea
    Dyke
    IV36 0TF Forres
    Moray
    British55621860001
    HOYCE, David Ernest
    Fishers Cottage
    Findhorn
    IV36 0YN Forres
    Moray
    Geschäftsführer
    Fishers Cottage
    Findhorn
    IV36 0YN Forres
    Moray
    British89253190001
    IVERSEN, Rolf
    The Park
    Findhorn
    IV36 3TZ Forres
    Moray
    Geschäftsführer
    The Park
    Findhorn
    IV36 3TZ Forres
    Moray
    Norway92041510001
    MABBOTT, Stephen
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish900008380001
    MACPHERSON-STEWART, Johnstone Findlay
    Greeshop House
    Forres
    IV36 2SN Moray
    Geschäftsführer
    Greeshop House
    Forres
    IV36 2SN Moray
    ScotlandScottish65513900002
    MOLNAR, Christian Nicholas
    The Croft
    Wester Lawrenceton Farm
    IV36 2RL Forres
    Moray
    Geschäftsführer
    The Croft
    Wester Lawrenceton Farm
    IV36 2RL Forres
    Moray
    ScotlandBritish75239850004
    NOBLE, Stewart Alexander
    60 Woodside Drive
    Sanquar
    IV36 0UF Forres
    Morayshire
    Geschäftsführer
    60 Woodside Drive
    Sanquar
    IV36 0UF Forres
    Morayshire
    British52904080001
    RAYMONT, Christopher
    Walker Court
    IV36 1ZQ Forres
    3
    Moray
    Geschäftsführer
    Walker Court
    IV36 1ZQ Forres
    3
    Moray
    ScotlandBritish129631790001
    RAYMONT, Christopher
    206
    Findhorn
    IV36 0YS Forres
    Morayshire
    Geschäftsführer
    206
    Findhorn
    IV36 0YS Forres
    Morayshire
    British61399670001
    READ, Philip David
    Clashdhu
    IV36 2QG Forres
    Moray
    Geschäftsführer
    Clashdhu
    IV36 2QG Forres
    Moray
    British127226420001
    ROLFE, Dawn Ann
    Greeshop House
    IV36 2SN Forres
    Moray
    Geschäftsführer
    Greeshop House
    IV36 2SN Forres
    Moray
    ScotlandBritish65513840002
    ROSENBUSCH, Mathis
    Sunnyside The Park
    Findhorn
    IV36 0TZ Forres
    Moray
    Geschäftsführer
    Sunnyside The Park
    Findhorn
    IV36 0TZ Forres
    Moray
    German39162070002
    SHAW, Carol Ann
    Delft Cottage
    Dyke
    IV36 2TF Forres
    Moray
    Geschäftsführer
    Delft Cottage
    Dyke
    IV36 2TF Forres
    Moray
    British27237610001
    SPEAKMAN, Sarah Jane
    22 Queen Street
    IV12 4AA Nairn
    Moray
    Geschäftsführer
    22 Queen Street
    IV12 4AA Nairn
    Moray
    British52904120001
    STEEL, David James
    Cullerne House
    IV36 3YY Findhorn
    Moray
    Geschäftsführer
    Cullerne House
    IV36 3YY Findhorn
    Moray
    British68288270002
    TODD, Kathleen Susan
    12 Roysvale Place
    IV36 1PN Forres
    Morayshire
    Geschäftsführer
    12 Roysvale Place
    IV36 1PN Forres
    Morayshire
    British104912360001
    TRUSSELL, Helen Ruth
    1 Logie Home Farm
    Dunphail
    TV36 2QN Moray
    Geschäftsführer
    1 Logie Home Farm
    Dunphail
    TV36 2QN Moray
    British65124860002

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0