Stephen MABBOTT
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Stephen |
Nachname | MABBOTT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 2448 |
Gesamt | 2449 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRNE RECRUITMENT LTD | 04. Feb. 1999 | 25. Feb. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
KIRKRIDGE LIMITED | 04. Feb. 1999 | 03. März 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
HANDY BUDDIES LTD. | 04. Feb. 1999 | 04. Feb. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GROWTH INSIDE OUT LTD | 04. Feb. 1999 | 04. Feb. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CITY ARTS & CORPORATE CATERING LTD. | 04. Feb. 1999 | 04. Feb. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BORDERVIEW LIMITED | 04. Feb. 1999 | 05. Feb. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
INSHES MOTOR COMPANY LIMITED | 03. Feb. 1999 | 03. Feb. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
UPLAND ACCESS LIMITED | 01. Feb. 1999 | 01. Feb. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GP SELECTIONS LIMITED | 01. Feb. 1999 | 01. Feb. 1999 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BRIAN REID LTD. | 01. Feb. 1999 | 26. Nov. 2016 | Aufgelöst | Company Regristration Agent | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Allan Park Gardens EH14 1LN Edinburgh 29 Scotland | Scotland | British |
GLOBAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED | 01. Feb. 1999 | 01. Feb. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
STEPHEN MABBOTT LTD. | 01. Feb. 1999 | Aufgelöst | Company Registration Agent | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2 Anderson Place EH6 5NP Edinburgh Millar & Bryce Limited, Bonnington Bond | Scotland | British | |
ONESTOP SCAFFOLDING LIMITED | 01. Feb. 1999 | 01. Feb. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ELGIN MOTORSPORT PROMOTIONS | 01. Feb. 1999 | 01. Feb. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
POWER & GENERATION SERVICES LIMITED | 01. Feb. 1999 | 01. Feb. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
LOCH TORRIDON HOTEL LIMITED | 29. Jan. 1999 | 29. Jan. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
A CALLAGHAN LTD. | 29. Jan. 1999 | 29. Jan. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
EV WORKS LIMITED | 29. Jan. 1999 | 29. Jan. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
IRIAM LIMITED | 28. Jan. 1999 | 28. Jan. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
TRAPRAIN TECHNOLOGY LIMITED | 28. Jan. 1999 | 28. Jan. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BLACK TAXIS LTD. | 27. Jan. 1999 | 27. Jan. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CLEAR CONTRACTING LIMITED | 27. Jan. 1999 | 23. Juni 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CUMMISH COMPANY LIMITED | 27. Jan. 1999 | 08. Feb. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
HERITAGE I.T. LIMITED | 27. Jan. 1999 | 28. Mai 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GRANITE SYSTEMS LIMITED | 27. Jan. 1999 | 01. Feb. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
FOS1 LTD. | 27. Jan. 1999 | 17. Feb. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BEACHWATCH BUTE | 26. Jan. 1999 | 22. Nov. 1999 | Umwandlung / Auflösung | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GAS SERVICES EAST LIMITED | 26. Jan. 1999 | 26. Jan. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CHUNG WAH TAO TAK TONG CHARITY COMPANY LIMITED | 25. Jan. 1999 | 13. Dez. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
T.G.O.S. LIMITED | 25. Jan. 1999 | 25. Jan. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ELMTREE HOMES LTD. | 25. Jan. 1999 | 25. Jan. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CITY LIMITS OUTDOOR ADVENTURES LIMITED | 25. Jan. 1999 | 25. Jan. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
D H B PROPERTIES LIMITED | 25. Jan. 1999 | 25. Jan. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ARNOLD CLARK INSURANCE SERVICES LIMITED | 22. Jan. 1999 | 22. Jan. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
STIRLING WOOD LTD. | 22. Jan. 1999 | 22. Jan. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British |
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0