• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • John David DOUGLAS - Seite 2

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameJohn
    Zweites VornamenDavid
    NachnameDOUGLAS
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv0
    Zurückgetreten163
    Gesamt163

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    CONDYLE LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    Burton Latimer
    Kettering
    NN15 5JP Northamptonshire
    ScotlandBritish
    CLEOMACK (ONE) LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    ACCESS FLOOR SYSTEMS LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    ALUMASC-GRUNDY LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    BENJAMIN PRIEST GROUP LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    EXPRESS SHOTBLASTING LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AufgelöstDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    ENGIRD LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    Burton Latimer
    Kettering
    NN15 5JP Northamptonshire
    ScotlandBritish
    CHARDENE DIE & TOOL COMPANY LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AufgelöstDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    ALUMASC EXTERIOR BUILDING PRODUCTS LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    YENOTS LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    HARVEY REED TOP TABLE LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    BENION LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    CLEOMACK (THREE) LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    SORREL 009 LIMITED03. Apr. 201201. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    ALUMASC PRECISION LIMITED16. Okt. 201001. Okt. 2016AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    ALUMASC BUILDING PRODUCTS LIMITED31. Dez. 201005. Sept. 2012AktivDeputy Group Company SecretaryGeschäftsführer
    C/O The Alumasc Group Plc
    Station Road Burton Latimer
    NN15 5JP Kettering
    Northamptonshire
    ScotlandBritish
    CAG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED11. Aug. 200830. Sept. 2008AufgelöstSekretär
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British
    M.M.I. RESEARCH LIMITED11. Aug. 200830. Sept. 2008AufgelöstSekretär
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British
    STRABOR (AIRCRAFT) LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorSekretär
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British
    STRABOR (AIRCRAFT) LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish
    STRATEGIC TANKER SERVICES LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorSekretär
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British
    COBHAM QUEST TRUSTEE LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorSekretär
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British
    SLINGSBY AMPHIBIOUS HOVERCRAFT LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish
    STRATEGIC TANKER SERVICES LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish
    COBHAM QUEST TRUSTEE LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish
    AIR PRECISION LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish
    COBHAM COMMS LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish
    SLINGSBY AMPHIBIOUS HOVERCRAFT LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorSekretär
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British
    COBHAM GROUP LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstSekretär
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British
    AIR PRECISION LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorSekretär
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British
    COBHAM AEROSPACE LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish
    MANLOCK INVESTMENTS LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish
    LOCKMAN PROPERTIES LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008LiquidationSekretär
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British
    W.E.S. (MANUFACTURING) LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish
    COBHAM COMMS LIMITED19. Juni 200830. Sept. 2008AufgelöstDirectorSekretär
    61 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0