John David DOUGLAS - Seite 3
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | John |
Zweites Vornamen | David |
Nachname | DOUGLAS |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 163 |
Gesamt | 163 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANLOCK INVESTMENTS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | |
COBHAM AEROSPACE LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | |
W.E.S. INVESTMENTS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | |
W.E.S. INVESTMENTS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | Scotland | British |
ML AIRCRAFT SERVICES LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | |
MULTIPHASE PUMPING SYSTEMS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | Scotland | British |
FLIGHT REFUELLING TARGETS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | |
FLIGHT REFUELLING TARGETS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | Scotland | British |
ML AIRCRAFT SERVICES LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | Scotland | British |
LOCKMAN ELECTRONIC HOLDINGS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | ||
MULTIPHASE PUMPING SYSTEMS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | |
COBHAM FLUID SYSTEMS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | ||
LOCKMAN FINANCING LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | ||
STRABOR INVESTMENTS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | Scotland | British |
STRABOR INVESTMENTS LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Aufgelöst | Director | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | |
LOCKMAN PROPERTIES LIMITED | 19. Juni 2008 | 30. Sept. 2008 | Liquidation | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | ||
SCOTTISHPOWER SHARESAVE TRUSTEES LIMITED | 20. Juli 2006 | 26. Okt. 2007 | Aufgelöst | Chartered Secretary | Geschäftsführer | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | Scotland | British |
STAG HOUSE TEN LIMITED | 26. Apr. 1999 | 20. Juni 2006 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
MALCOLM PROPERTIES LIMITED | 01. Jan. 2002 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Sekretär | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | ||
BLACK MOUSE MANAGEMENT LIMITED | 25. Mai 2000 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
BLACK MOUSE MANAGEMENT LIMITED | 25. Mai 2000 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Company Secretary | Sekretär | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
GRAMPIAN SPORTS LIMITED | 19. Jan. 2000 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
STAG HOUSE FIVE LIMITED | 29. Jan. 1999 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Deputy Company Secretary | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
STAG HOUSE FIVE LIMITED | 29. Jan. 1999 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Deputy Company Secretary | Sekretär | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
STAG HOUSE 6 LIMITED | 01. Dez. 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | Scotland | British |
STAG HOUSE THREE LIMITED | 01. Dez. 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
STAG HOUSE EIGHT LIMITED | 24. Sept. 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Company Secretary | Sekretär | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | British | |
STAG HOUSE EIGHT LIMITED | 24. Sept. 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | 61 Menteith View FK15 0PD Dunblane Perthshire | Scotland | British |
MILLARD BROTHERS,LIMITED | 31. Juli 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
MARSHALL EQUIPMENT HIRE LIMITED | 31. Juli 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
GRAMPIAN TECHNICAL SERVICES LIMITED | 31. Juli 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
GRAMPIAN OIL SERVICES LIMITED | 31. Juli 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
GRAMPIAN INDUSTRIES LIMITED | 31. Juli 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
RODDY INTERNATIONAL LIMITED | 31. Juli 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British | |
G.T.S.ELECTRONICS LIMITED | 31. Juli 1998 | 01. Nov. 2005 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | 20 Ashley Avenue FK14 7EG Dollar Clackmannanshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0