JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED - Seite 37
Unternehmensleiter
Name | JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 2 |
Inaktiv | 109 |
Zurückgetreten | 1705 |
Gesamt | 1816 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
ZINC HOUSE MANAGEMENT LIMITED | 28. Apr. 2000 | 04. Okt. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
CPL OPERATIONS LIMITED | 13. Feb. 2001 | 19. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
COIM UK LIMITED | 04. Juli 2001 | 17. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
GORICARDO.CO.UK INTERNET AUCTIONS LTD | 11. Okt. 1999 | 11. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
DOORS & WINDOWS DIRECT LIMITED | 12. Sept. 2000 | 31. Aug. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
CELCIUS (UK) LIMITED | 13. Sept. 1999 | 31. Aug. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
RINGER DEVELOPMENTS LIMITED | 22. Sept. 1999 | 24. Aug. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
TIDESDALE LTD | 22. Mai 2000 | 21. Aug. 2001 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
BST BALTIC SEA TRANSPORTATION COMPANY LTD | 06. Okt. 1999 | 16. Aug. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
KRUSE MOTORSPORT LIMITED | 28. Juli 2000 | 13. Aug. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
ALLIANCE VORTEX LIMITED | 11. Mai 2000 | 07. Aug. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
ALFRED COUK WINE AND SPIRITS LIMITED | 23. Dez. 1998 | 03. Aug. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
AGILITY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED | 01. Juni 2001 | 02. Aug. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
GLOBAL-SSB RESEARCH LABORATORIES LIMITED | 11. März 1999 | 16. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
BOOKER MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 28. Apr. 2001 | 12. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
12 PEMBRIDGE SQUARE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 08. Juli 1999 | 09. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
MAINPOWER PLC | 04. Nov. 1998 | 06. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
REAL PEOPLE SCOTLAND LIMITED | 24. Jan. 2000 | 05. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
GRACE & CO ENTERPRISES LIMITED | 28. Apr. 2000 | 03. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
ARNOLD MAGNETIC TECHNOLOGIES LIMITED | 30. Juni 2000 | 01. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
SIDEL (UK) LIMITED | 01. Juni 2001 | 26. Juni 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
JOSEPH PUBLISHING LIMITED | 26. Juni 2001 | 26. Juni 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
DOORS CONSULTING LTD. | 16. Juni 1994 | 19. Juni 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
SPRING SCIENTIFIC LIMITED | 10. Juli 1995 | 12. Juni 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
INVUS (UK) LIMITED | 27. Okt. 2000 | 10. Juni 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
CELTIC RESOURCES (CENTRAL ASIA) LIMITED | 28. Juli 1999 | 05. Juni 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
GLASSMEDIA LIMITED | 26. Juni 2000 | 31. Mai 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
NATURAL SCIENTIFIC SOLUTIONS LTD | 26. Jan. 2000 | 23. Mai 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
KEYDATA GENERAL PARTNER 1 LIMITED | 19. Juli 2000 | 14. Mai 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
KEYDATA INVESTMENT SERVICES LIMITED | 12. Feb. 1999 | 14. Mai 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
KEYDATA INVESTMENT PRODUCTS NOMINEES LIMITED | 07. Jan. 1999 | 14. Mai 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
BLENDRITE LIMITED | 24. März 1999 | 23. Apr. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
O-VIDEO LIMITED | 15. Mai 1998 | 19. Apr. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
METROTILE (U.K.) LIMITED | 04. Apr. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon | |
CHISEUIL CASTLE LTD | 26. März 1997 | 23. März 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
Zurück2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0