JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED - Seite 5
Unternehmensleiter
Name | JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED |
---|---|
Ist Unternehmensleiter | Ja |
Ernennungen | |
Aktiv | 2 |
Inaktiv | 109 |
Zurückgetreten | 1705 |
Gesamt | 1816 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Rolle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
FREEDOM SPORTSLINE LIMITED | 01. Sept. 1999 | 18. Jan. 2017 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
FOOT LOCKER U.K. LIMITED | 01. Sept. 1999 | 18. Jan. 2017 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
TWINWOOD LIMITED | 18. Nov. 2003 | 10. Jan. 2017 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
VALUE MANAGEMENT CONSULTANTS LTD | 29. Nov. 2003 | 09. Jan. 2017 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
LOGIC SOFTWARE INTERNATIONAL LTD | 11. Dez. 1992 | 28. Nov. 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
PRIVATE EQUITY AND CORPORATE DEBT FINANCING (UK) CO. LTD | 09. März 1994 | 22. Nov. 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
CHARLOTTE NEW AGE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 22. Mai 1998 | 18. Nov. 2016 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
WEBSENSE SC HOLDINGS LIMITED | 24. Juni 2008 | 25. Juli 2016 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
SURFCONTROL LIMITED | 24. Juni 2008 | 25. Juli 2016 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
WEBSENSE SC OPERATIONS LIMITED | 24. Juni 2008 | 25. Juli 2016 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
FORCEPOINT CLOUD LIMITED | 24. Juni 2008 | 25. Juli 2016 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
FORCEPOINT UK LIMITED | 24. Juni 2008 | 25. Juli 2016 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
FORCEPOINT OVERSEAS LIMITED | 24. Juni 2008 | 25. Juli 2016 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
SURFCONTROL (CHINA) LIMITED | 24. Juni 2008 | 25. Juli 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
TYNE AGENCIES LIMITED | 31. Jan. 2003 | 06. Juli 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
BLANDFORD DRILLING COMPANY LIMITED | 31. Jan. 2003 | 06. Juli 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
PHOENIX PROPERTY DEVELOPMENT CO. LTD. | 15. Mai 1998 | 01. Juli 2016 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
FLAWHURST (NO.2) LIMITED | 31. Jan. 2003 | 16. Juni 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
CHEWY SOLUTIONS LTD | 25. Nov. 2003 | 21. Apr. 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
FILENEED PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 16. März 2016 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon | |
A1 MEDICAL SERVICES LIMITED | 17. Sept. 2003 | 25. Feb. 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
ARYSTA LIFESCIENCE U.K. LIMITED | 21. Jan. 2009 | 12. Feb. 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | St. Thomas Street BS1 6JS Bristol 21 Avon |
PULTENEY BRIDGE CONSULTANCY LIMITED | 24. Nov. 1997 | 05. Feb. 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
LANDMARK NORTHERN LIMITED | 28. März 2003 | 29. Jan. 2016 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
PENINSULA PETROLEUM (BROKERS) LIMITED | 05. Dez. 2003 | 29. Dez. 2015 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
MCKENZIE ESTATES (NORTH) LIMITED | 10. Feb. 2003 | 18. Nov. 2015 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
VIKING OIL UK LIMITED | 06. Juli 2000 | 01. Okt. 2015 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
SAGE UK SERVICES LIMITED | 20. Okt. 2003 | 26. Aug. 2015 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
BLOOMINGDALE PROPERTIES (EUROPE) LTD. | 22. Mai 1998 | 21. Juli 2015 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
PAN EUROPEAN PROFESSIONAL REAL ESTATE DEVELOPERS LTD. | 10. Mai 1994 | 21. Juli 2015 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
CAPITAL FUNDING INVESTMENT TRUST LIMITED | 17. Okt. 1994 | 29. Juni 2015 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
FINCH LIMITED | 18. Jan. 1994 | 29. Juni 2015 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
NEWFONT LIMITED | 28. Mai 2002 | 23. Juni 2015 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
STARFORT LIMITED | 28. Mai 2002 | 23. Juni 2015 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
FONTVIEW LIMITED | 28. Mai 2002 | 23. Juni 2015 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon |
Zurück2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0