Richard John HOWSON - Seite 2
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Richard |
Zweites Vornamen | John |
Nachname | HOWSON |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 61 |
Gesamt | 61 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ST INSULATION PARTNERS LIMITED | 08. Juni 2011 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
GEORGE HOWE LIMITED | 08. Juni 2011 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
TPS CONSULT LIMITED | 23. Mai 2011 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED | 23. Mai 2011 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION ENERGY SERVICES LIMITED | 20. Apr. 2011 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
PME PARTNERSHIPS LIMITED | 15. Dez. 2010 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION SERVICES LIMITED | 15. Dez. 2010 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION SERVICES 2006 LIMITED | 15. Dez. 2010 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION ASSET MANAGEMENT LIMITED | 15. Dez. 2010 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION (AMBS) LIMITED | 15. Dez. 2010 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION CONSTRUCTION LIMITED | 10. Dez. 2009 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION (ASPIRE SERVICES) LIMITED | 10. Dez. 2009 | 15. Jan. 2018 | Aufgelöst | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION (AM) LIMITED | 10. Dez. 2009 | 15. Jan. 2018 | Liquidation | Executive Director | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION PRIVATE FINANCE (HEALTH) 2013 LIMITED | 20. Sept. 2013 | 31. Dez. 2017 | Liquidation | Group Chief Executive | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
CARILLION PLC | 10. Dez. 2009 | 10. Juli 2017 | Liquidation | Chief Executive | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (HEALTH) LIMITED | 06. Feb. 2012 | 30. Juni 2015 | Aktiv | Group Chief Executive | Geschäftsführer | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British |
RENEWABLE CLEAN ENERGY LIMITED | 08. Juni 2011 | 27. Juni 2014 | Aktiv | Executive Director | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British |
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (DEFENCE) LIMITED | 06. Feb. 2012 | 24. Dez. 2013 | Aktiv | Group Chief Executive | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British |
EAGA HEATING LIMITED | 08. Juni 2011 | 08. Okt. 2013 | Aufgelöst | Executive Director | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British |
EAGA RENEWABLES LIMITED | 08. Juni 2011 | 08. Okt. 2013 | Aufgelöst | Executive Director | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British |
HORROCKS GROUP PLC | 08. Juni 2011 | 08. Okt. 2013 | Aufgelöst | Executive Director | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British |
PROTOCOL COMMUNICATIONS MANAGEMENT LIMITED | 08. Juni 2011 | 08. Okt. 2013 | Aufgelöst | Executive Director | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British |
DEBIND INTERNATIONAL (UK) LTD. | 08. Juni 2011 | 08. Okt. 2013 | Aufgelöst | Executive Director | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British |
NATIONBROOK LIMITED | 08. Juni 2011 | 08. Okt. 2013 | Aufgelöst | Executive Director | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British |
BSF NEWCO LIMITED | 06. Feb. 2012 | 26. Sept. 2012 | Aktiv | Group Chief Executive | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British |
PERMAROCK PRODUCTS LIMITED | 08. Juni 2011 | 31. Aug. 2012 | Aktiv | Executive Director | Geschäftsführer | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0