OTIS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOTIS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00147366
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OTIS LIMITED?

    • fabricación de equipos de elevación y manipulación (28220) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra OTIS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    10th Floor Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OTIS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EXPRESS LIFT COMPANY LIMITED(THE)03 may 191703 may 1917

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OTIS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 nov 2025
    Próximas cuentas vencen el31 ago 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para OTIS LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta31 ago 2025
    Próxima declaración de confirmación vence14 sept 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta31 ago 2024
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OTIS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Modification des détails de Otis Uk Holding Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 nov 2024

    2 páginasPSC05

    legacy

    páginasANNOTATION

    Cessation de Otis Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 nov 2024

    1 páginasPSC07

    Segunda presentación para la notificación de Otis Elevator Holdings Limited como persona con control significativo

    4 páginasRP04PSC02

    legacy

    4 páginasRP04SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2024

    48 páginasAA

    Nombramiento de Simon Fahmy como director el 09 jul 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Dean White como director el 09 jul 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paschal Lennon como director el 16 abr 2025

    1 páginasTM01

    Modification des détails de Otis Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 nov 2024

    2 páginasPSC05

    Notification de Otis Elevator Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 nov 2024

    3 páginasPSC02
    Anotaciones
    FechaAnotación
    24 sept 2025Clarification A second filed PSC02 was registered on 24/09/2025.

    Cese del nombramiento de Carlos Arango como director el 26 mar 2025

    1 páginasTM01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 26 nov 2024

    • Capital: GBP 233,872,000
    4 páginasSH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    22 sept 2025Clarification A second filed SH01 was registered on 22/09/2025

    Nombramiento de Mr Rajpal Singh como director el 25 oct 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Maxime Yao como director el 25 oct 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2023

    48 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Ales Korotvicka como director el 10 abr 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Emma Clare Bryan como director el 10 abr 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Steven Bierer como director el 10 abr 2024

    1 páginasTM01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2022

    48 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cambio de datos del director Mr Maxime Yao el 20 oct 2023

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Alex Lampe como director el 15 sept 2023

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de OTIS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EDWIN COE SECRETARIES LIMITED
    Stone Buildings
    Lincoln’S Inn
    WC2A 3TH London
    2
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Stone Buildings
    Lincoln’S Inn
    WC2A 3TH London
    2
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro04586068
    98679750001
    FAHMY, Simon
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    Director
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    EnglandBritish337834310001
    KOROTVICKA, Ales
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    Director
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    Czech RepublicCzech322026980001
    SADLER, Robert William
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    Director
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    EnglandBritish107127030002
    SINGH, Rajpal
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    Director
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    EnglandBritish328736740001
    WHITE, Dean Charles Leonard
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    Director
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    EnglandBritish113705770004
    CALE-MORGAN, David Philip
    10 Hunsbury Close
    West Hunsbury
    NN4 9UE Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    10 Hunsbury Close
    West Hunsbury
    NN4 9UE Northampton
    Northamptonshire
    British36646370001
    CARROLL, Adrian
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    Secretario
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    238133220001
    CUST, Gary William
    Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    27
    Berkshire
    Secretario
    Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    27
    Berkshire
    British193071220001
    FELLOWS, Nicole
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    Oak House
    England
    Secretario
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    Oak House
    England
    236728550001
    KIRK, Caroline Emma Clarke
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United Kingdom
    Secretario
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United Kingdom
    173131620001
    MAISEY, John Anthony
    3 Ashby Road
    Twyford
    LE14 2HN Melton Mowbray
    Leicestershire
    Secretario
    3 Ashby Road
    Twyford
    LE14 2HN Melton Mowbray
    Leicestershire
    British34784770002
    PATE, Carolyn
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United Kingdom
    Secretario
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United Kingdom
    160664900001
    SMART, Gregory Paul
    8 Home Acre
    NN7 1AG Little Houghton
    Northamptonshire
    Secretario
    8 Home Acre
    NN7 1AG Little Houghton
    Northamptonshire
    British6055260004
    WILCOCK, Laura
    Lions Drive
    BB1 2QS Blackburn
    Number One @ The Beehive
    England
    Secretario
    Lions Drive
    BB1 2QS Blackburn
    Number One @ The Beehive
    England
    203286590001
    ABAJO, Mario
    Av Carondelet 10a
    FOREIGN Madrid
    28043
    Spain
    Director
    Av Carondelet 10a
    FOREIGN Madrid
    28043
    Spain
    Spanish37386310002
    ARANGO, Carlos
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    Director
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    EnglandBritish266374700001
    BAKER, John
    Hillside Whitehough
    Chinley
    SK12 6BX Stockport
    Cheshire
    Director
    Hillside Whitehough
    Chinley
    SK12 6BX Stockport
    Cheshire
    British46406860001
    BAKER, John
    Hillside Whitehough
    Chinley
    SK12 6BX Stockport
    Cheshire
    Director
    Hillside Whitehough
    Chinley
    SK12 6BX Stockport
    Cheshire
    British46406860001
    BALL, Keith George
    187 Twyford Abbey Road
    NW10 7DG London
    The Otis Building
    Director
    187 Twyford Abbey Road
    NW10 7DG London
    The Otis Building
    EnglandBritish116992380001
    BALL, Keith George
    16 Triumph Road
    Glenfield
    LE3 8FR Leicester
    Leicestershire
    Director
    16 Triumph Road
    Glenfield
    LE3 8FR Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish116992380001
    BATTY, Michele Louise
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    Director
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United KingdomBritish254221640001
    BATTY, Michèle Louise
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United Kingdom
    Director
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United Kingdom
    EnglandBritish179213390001
    BELL, Stephen Christopher
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United Kingdom
    Director
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United Kingdom
    EnglandBritish174529340001
    BIERER, Andrew Steven
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    Director
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    EnglandAmerican268017370001
    BISSON, Rene
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    Director
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    EnglandAmerican254220370001
    BRYAN, Emma Clare
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    Director
    Vantage
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor
    England
    EnglandBritish283579910001
    CALE-MORGAN, David Philip
    10 Hunsbury Close
    West Hunsbury
    NN4 9UE Northampton
    Northamptonshire
    Director
    10 Hunsbury Close
    West Hunsbury
    NN4 9UE Northampton
    Northamptonshire
    British36646370001
    CARSE, Thomas
    224 Acre Lane
    NN2 8DX Northampton
    Northamptonshire
    Director
    224 Acre Lane
    NN2 8DX Northampton
    Northamptonshire
    British30474250001
    CATTERALL, Philip Brian
    Cross Cottage 3 The Cross
    Hallaton
    LE16 8UA Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    Cross Cottage 3 The Cross
    Hallaton
    LE16 8UA Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish71774660001
    CUST, Gary William
    Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    27
    Berkshire
    Director
    Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    27
    Berkshire
    EnglandBritish193071220001
    DERWIN, William
    Nassau Road
    SW13 9QF London
    33
    Director
    Nassau Road
    SW13 9QF London
    33
    United KingdomAmerican156988760001
    DURANDET, Geoffroy Andre
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United Kingdom
    Director
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    United Kingdom
    EnglandFrench172275260001
    ELEY, Michael John
    Beech House Beech Lane
    Kislingbury
    NN7 4AL Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Beech House Beech Lane
    Kislingbury
    NN7 4AL Northampton
    Northamptonshire
    British3178860001
    FORBES, Craig Alexander
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    Director
    Building 5, Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park
    EnglandBritish78875010004

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de OTIS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor Vantage
    United Kingdom
    26 nov 2024
    Great West Road
    TW8 9AG Brentford
    10th Floor Vantage
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00785105
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Otis Investments Limited
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park Building 5, Ground Floor
    England
    07 may 2019
    566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    Chiswick Park Building 5, Ground Floor
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Chiswick Park Building 5 Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    London
    Chiswick Park Building
    England
    10 oct 2018
    Chiswick Park Building 5 Ground Floor
    566 Chiswick High Road
    London
    Chiswick Park Building
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2008
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05783481
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Ash House
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    1st Floor
    England
    06 abr 2016
    Ash House
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    1st Floor
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00184806
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para OTIS LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    31 ago 201610 oct 2018La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0