RAINRAM INVESTMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RAINRAM INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00574886 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RAINRAM INVESTMENTS LIMITED?
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra RAINRAM INVESTMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 25 Savile Row London W1S 2ER |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RAINRAM INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAINRAM INVESTMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||
Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones | 2 páginas | SH10 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 30 nov 2017
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy James Kite como secretario el 02 oct 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Andrew Lawler como secretario el 02 oct 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 sept 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 sept 2016 con actualizaciones | 8 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 sept 2014 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Misceláneos Section 519 | 3 páginas | MISC | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 sept 2013 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 sept 2012 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 34 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RAINRAM INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWLER, David Andrew | Secretario | 25 Savile Row London W1S 2ER | 238984360001 | |||||||
| BURNS, John David | Director | Flat 3 33/36 Chester Square SW1W 9HT London | United Kingdom | British | 9820610002 | |||||
| GEORGE, Nigel Quentin | Director | 32 Lancaster Gardens Wimbledon SW19 5DG London United Kingdom | England | British | 26640150004 | |||||
| SILVER, Simon Paul | Director | 49 Hamilton Terrace NW8 9RG London | England | British | 35534690001 | |||||
| SILVERMAN, David Gary | Director | 10 Heath Close NW11 7DX London | United Kingdom | British | 126851570001 | |||||
| WILLIAMS, Paul Malcolm | Director | 24 Kimpton Road Blackmore End Wheathampstead AL4 8LD St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 10072820003 | |||||
| WISNIEWSKI, Damian Mark Alan | Director | Savile Row W1S 2ER London 25 | England | British | 148838200001 | |||||
| KITE, Timothy James | Secretario | Arisaig Reading Road North GU51 4HP Fleet Hampshire | British | 107553690001 | ||||||
| MITCHLEY, Simon Colin | Secretario | 34 Harris Lane Shenley WD7 9EG Radlett Hertfordshire | British | 53655170004 | ||||||
| WALDRON, Michael | Secretario | 14 Wimpole Mews W1G 8PE London | British | 8811160003 | ||||||
| DRIVER, Nicholas Gordon Ellis | Director | Pullens Cottage 2 Leigh Hill Road KT11 2HX Cobham Surrey | England | British | 8811170002 | |||||
| FRIEDLOS, Nicholas Robert | Director | 13 Alwyne Road N1 2HH London | England | British | 61183260002 | |||||
| GROVES, Nicholas Thomas Julian | Director | 37 Vicarage Road East Sheen SW14 8PZ London | United Kingdom | British | 157469310001 | |||||
| MILLSOM, Walter | Director | 3 Tollgate Drive College Road Dulwich SE21 7LS London | England | British | 16095080001 | |||||
| ODOM, Christopher James | Director | 19 Embercourt Road KT7 0LH Thames Ditton Surrey | British | 20951000001 | ||||||
| PEXTON, Martin Andrew | Director | Little Kensham Farm, Sandhurst Lane Rolvenden TN17 4PH Cranbrook Kent | England | British | 87643530001 | |||||
| RAYNE, Max, Lord | Director | 33 Robert Adam Street W1U 3HR London | British | 35619240001 | ||||||
| RAYNE, Robert Anthony, The Honourable | Director | 37 Brunswick Gardens W8 4AW London | England | British | 53009350001 | |||||
| SPIER, Robert Fitzhardinge Jenner | Director | The Barn High Street North Stewkley LU7 0EZ Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 8842440001 | ||||||
| WALDRON, Michael | Director | 14 Wimpole Mews W1G 8PE London | British | 8811160003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RAINRAM INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derwent Valley Limited | 06 abr 2016 | Savile Row W1S 2ER London 25 London England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene RAINRAM INVESTMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creado el 24 feb 2006 Entregado el 03 mar 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Its interest in the deposit account and all money from time to time paid into it. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Second supplemental trust deed | Creado el 22 nov 2002 Entregado el 28 nov 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the issuer or any substitute principal debtor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción First floating charge over all undertaking,property and assets whatsoever including any uncalled capital; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Third supplemental trust deed | Creado el 20 ene 1992 Entregado el 21 ene 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The principal of and interest on the £100,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of london merchant securities PLC and all other moneys due or to become due to the law debenture trust corporation P.L.C. (the "trustee") under the third supplemental trust deed and the trust deed dated 22ND march 1988 and the deeds supplemental thereto dated 16TH november 1989 and 30TH september 1991 to which the said third supplemental trust deed is supplemental (including £60,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of london merchant securities PLC already issued) | |
Breve descripción Coventry house,3 south place,finsbury,london,EC2 spencer house,4 south place,finsbury,london,EC2 all moneys to be received by virtue of any insurances (see doc ref M94 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0