RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED

RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00719804
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    • Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LRG HOTELS GROUP (UK) LIMITED03 jun 200503 jun 2005
    INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (UK) LIMITED17 abr 200317 abr 2003
    SIX CONTINENTS HOTELS (UK) LIMITED06 ago 200106 ago 2001
    BASS HOTELS & RESORTS (UK) LIMITED13 ene 200013 ene 2000
    HOLIDAY INNS (UK) LIMITED10 ago 199010 ago 1990
    BASS HOTELS AND HOLIDAYS (UK) LIMITED16 sept 198516 sept 1985
    PONTIN'S(BOURNEMOUTH)LIMITED29 mar 196229 mar 1962

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 nov 2018

    16 páginasLIQ03

    Cese del nombramiento de Justin Bruce Robinson como director el 14 sept 2018

    1 páginasTM01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 22 dic 2017

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    6 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 nov 2017

    LRESSP

    Cambio de datos del secretario Haysmacintyre Company Secretaries Limited el 18 dic 2017

    1 páginasCH04

    Domicilio social registrado cambiado de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG el 18 dic 2017

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Mr Simon Michael Teasdale el 18 dic 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Patrick Thomas Mabry el 18 dic 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 18 dic 2017

    2 páginasCH01

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 007198040008

    5 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 007198040009

    5 páginasMR05

    Cambio de datos del director Mr Patrick Thomas Mabry el 17 nov 2017

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    29 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 03 oct 2017

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 007198040008

    5 páginasMR05

    Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 007198040008

    5 páginasMR05

    ¿Quiénes son los directivos de RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4682161
    89121630002
    MABRY, Patrick Thomas
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Director
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    LuxembourgGerman204005420001
    TEASDALE, Simon Michael
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Director
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish204008350001
    BRIDGE, Michael John Noel
    17 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NW London
    Secretario
    17 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NW London
    British36370370001
    ENGMANN, Catherine
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    Secretario
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    British92722710002
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Secretario
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    203613710001
    WATERS, Paul Christopher
    23 Derby Road
    Cheam
    SM1 2BL Sutton
    Surrey
    Secretario
    23 Derby Road
    Cheam
    SM1 2BL Sutton
    Surrey
    British32282110001
    WHITNEY, Paul Sumpter
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    Secretario
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    British418890001
    WILLIAMS, Alison
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    Secretario
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    British78744290002
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4682161
    89121630002
    PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
    Bishops Square
    E1 6EG London
    Ten
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Bishops Square
    E1 6EG London
    Ten
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro04131463
    125623230001
    BAKER, Skardon Francis
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Director
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United KingdomAmerican196342720001
    BURKE, Michael Ian
    Rue Mignot Delstranche 70
    FOREIGN 1060 Brussels
    Belgium
    Director
    Rue Mignot Delstranche 70
    FOREIGN 1060 Brussels
    Belgium
    British50280660001
    BUTCHER, Kenneth Frederick
    Applegarth Moorlane
    South Newington
    OX15 4JQ Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Applegarth Moorlane
    South Newington
    OX15 4JQ Banbury
    Oxfordshire
    British1835140001
    CASTON, Robert Warwick
    Square De Heeus 20
    FOREIGN 1400 Brussels
    Belgium
    Director
    Square De Heeus 20
    FOREIGN 1400 Brussels
    Belgium
    British1311840002
    CLARKE, Timothy
    63 Wellington Road
    B15 2ET Edgbaston
    Birmingham
    Director
    63 Wellington Road
    B15 2ET Edgbaston
    Birmingham
    EnglandBritish149229730001
    COWIE, Graham Michael
    Fir Tree Cottage Rays Lane
    Tylers Green
    HP10 8LH Penn
    Buckinghamshire
    Director
    Fir Tree Cottage Rays Lane
    Tylers Green
    HP10 8LH Penn
    Buckinghamshire
    EnglandBritish63239220001
    EKAS, Petra Cecilia Maria
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Director
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    United KingdomDutch169731050002
    FISH, Andrew John
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Director
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish77133450001
    GRAHAM, Ian Christopher
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    Director
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    British31551670001
    JACKMAN, Robert Loehr
    4 Durning Place
    SL5 7EZ Ascot
    Berkshire
    Director
    4 Durning Place
    SL5 7EZ Ascot
    Berkshire
    American35835670003
    KOLEV, Ivaylo
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Director
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    UkBulgarian193389430001
    LANGTON, Bryan David
    4185 Fairway Villas Drive
    Alpharetta
    Georgia 30202
    Usa
    Director
    4185 Fairway Villas Drive
    Alpharetta
    Georgia 30202
    Usa
    British57659820001
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Director
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish241370450001
    MCCARTHY, John Patrick
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    Director
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    United States112396050001
    MCEWAN, Allan Scott
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Director
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish75569660002
    MITCHELL, Paul Raymond
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    Director
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    EnglandBritish148147140001
    NEWMAN, Mark
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    Director
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    United KingdomCanadian62529820001
    PRINCE, Ryan David
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomCanadian85682450077
    REES, Sally Irene
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    Director
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    EnglandBritish49954790002
    RITSON, Leslie David
    Old Middle Cator House
    Cator Widecombe In The Moor
    TQ13 7UA Newton Abbot
    Devonshire
    Director
    Old Middle Cator House
    Cator Widecombe In The Moor
    TQ13 7UA Newton Abbot
    Devonshire
    British26098610002
    RITSON, Leslie David
    The Nettles
    Cossington Road Sileby
    LE12 7RR Loughborough
    Leicestershire
    Director
    The Nettles
    Cossington Road Sileby
    LE12 7RR Loughborough
    Leicestershire
    British26098610001
    ROBINSON, Justin Bruce
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Director
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish225299130001
    ROBINSON, Sarah Margaret Anne
    9 Berkeley Lodge
    Sandal Road
    KT3 5AW New Malden
    Surrey
    Director
    9 Berkeley Lodge
    Sandal Road
    KT3 5AW New Malden
    Surrey
    EnglandBritish67669280002
    SPRINGETT, Catherine Mary
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    Director
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    United KingdomBritish147336720001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00368815
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 dic 2015
    Entregado el 02 dic 2015
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent))
    Transacciones
    • 02 dic 2015Registro de una carga (MR01)
    • 18 dic 2017Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    A registered charge
    Creado el 01 dic 2015
    Entregado el 02 dic 2015
    Pendiente
    Breve descripción
    L/H property k/a bristol hotel, 5-7 (inc) berkeley street, 49 dover street and 69-72 (inc) piccadilly london t/no NGL854901 and l/h property k/a holiday inn, manor lane, maidenhead and all other plots of land in the instrument. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent))
    Transacciones
    • 02 dic 2015Registro de una carga (MR01)
    • 13 jun 2017Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 05 sept 2017Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 18 dic 2017Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    A registered charge
    Creado el 22 may 2013
    Entregado el 04 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag, London Branch, for Itself and as Security Trustee for the Common Secured Parties
    Transacciones
    • 04 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 03 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 22 may 2013
    Entregado el 04 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag, London Branch, for Itself and as Security Trustee for the Common Secured Parties
    Transacciones
    • 04 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 03 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 22 may 2013
    Entregado el 03 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    L/H 129 st nicholas circle leicester t/no LT57900, l/h bristol hotel 5-7 (inc) berkeley street, 49 dover street and 69-72 (inc) piccadilly london t/no NGL854901, l/h land on the north side of cheam road t/no SGL530893 and f/h land at grange employment area woolston warrington t/no CH325746. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutshce Bank Ag, London Branch (The Common Security Agent)
    Transacciones
    • 03 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 04 sept 2014Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 07 abr 2015Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 03 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 20 jun 2005
    Entregado el 28 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 28 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 04 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 20 jun 2005
    Entregado el 22 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 22 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 04 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Intercreditor agreement between the parent, the guarantors, the senior lenders, the junior creditor, the hi creditor (each as defined therein) and the agent (the "intercreditor")
    Creado el 20 mar 2000
    Entregado el 04 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee all present and future liabilities payable or owing by the obligors to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents
    Breve descripción
    Non-permitted payment if: (a)a subordinated creditor receives a payment or distribution in cash or kind in respect of or on account of any of the subordinated debt from an obligor or any other source except for a permitted payment - for further details see form 395.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Agent")
    Transacciones
    • 04 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 13 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed legal charge
    Creado el 03 dic 1999
    Entregado el 17 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All secured liabilities of bass PLC pursuant to the trust deed dated 12 february 1993
    Breve descripción
    F/H property k/a crowne plaza heathrow stockley road west drayton t/n ngl 160680.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Pension Trust Corporation PLC
    Transacciones
    • 17 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 nov 2017Inicio de la liquidación
    03 jul 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Ian Harvey Dean
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0