COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01359521 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Dirección de la sede social | Countryside House The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Essex |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
COUNTRYSIDE BUILD (SOUTHERN) LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
MADMILD LIMITED | 23 mar 1978 | 23 mar 1978 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Gary Neville Whitaker el 02 ago 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael Ian Scott el 04 feb 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Stewart Cherry como director el 30 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Gary Neville Whitaker como director el 01 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Ian Scott como director el 01 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Stephen Cherry como director el 30 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2014 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Richard Stephen Cherry el 23 sept 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2013 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 mar 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2012 | 1 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARREN, Tracy Marina | Secretario | Hollow Road Felsted CM6 3JF Dunmow The Molehill Essex United Kingdom | British | 132463120001 | ||||||
SCOTT, Michael Ian | Director | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | Financial Controller | 290228130001 | ||||
WHITAKER, Gary Neville | Director | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | General Counsel | 238965410002 | ||||
HOYLES, Robin Patrick | Secretario | 12 Springpark Drive BR3 6QD Beckenham Kent | British | 34860250001 | ||||||
PEARCE, Michael Frank | Secretario | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | British | 33032910001 | ||||||
SHILLINGLAW, Gary Preston | Secretario | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||
CHERRY, Alan Herbert | Director | Harvesters Green Street Fryerning CM4 ONS Ingatestone Essex | England | British | Chartered Surveyor | 2026150001 | ||||
CHERRY, Graham Stewart | Director | Fridays Fox Road Mashbury CM1 4TJ Chelmsford Essex | United Kingdom | British | Chief Executive | 7228590002 | ||||
CHERRY, Richard Stephen | Director | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | Company Director | 68733260003 | ||||
PEARCE, Michael Frank | Director | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | England | British | Chartered Accountant | 33032910001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Countryside Properties (Uk) Limited | 06 abr 2016 | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creado el 31 ene 1995 Entregado el 21 feb 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or countryside properties PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a land at prospect royal edinburgh way harlow essex and the proceeds of sale thereof and goodwill of the company in connection of any business or businesses carried on at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 14 jun 1993 Entregado el 25 jun 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The f/h property 19-37 (odd numbers only) goods station yard tunbridge wells and the proceeds of sale thereof, title no:- K678728 and an assignment of the goodwill and connection of any business,together with the full benefit of all licences.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 03 oct 1989 Entregado el 20 oct 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of any facility letter or other agreement or agreements (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 03 oct 1989 Entregado el 11 oct 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land with the buildings erected thereon or on some part or parts thereof situate at and fronting goods station road, and belgrave road, tunbridge wells, county of kent. K/a 19/37 (odd nos) goods station road, tunbridge wells, kent. T/n:- K607298. Together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 02 may 1986 Entregado el 20 may 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whtsoever. | |
Breve descripción F/H land on the east side of oakhill road savenoaks, kent. Part of title no:- K470174. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 02 may 1986 Entregado el 20 may 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción F/H land on the east side of oakhill road sevenoaks, kent, title no:- k 470174 (part of). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 22 abr 1985 Entregado el 30 abr 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whatsover. | |
Breve descripción Land and buildings known as 16A st. Johns road tunbridge wells kent title no. K 484471. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 18 mar 1985 Entregado el 26 mar 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the and/or countryside properties public limited company to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción 20 st john's road, tunbridge wells, kent title no. K 484471. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 02 nov 1984 Entregado el 20 nov 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the countryside properties public limited company to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción 33 & 35 eleanor cross road, waltham cross, broxbourne, hertfordshire title no. Hd 153666 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 02 nov 1984 Entregado el 09 nov 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from countryside properties PLC on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge | |
Breve descripción F/H land on the southside of st james road brentwood, essex. Title no ex 262151. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 08 abr 1981 Entregado el 21 abr 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H 94 the heights,foxgrove rd.,beckenham borough of bramley title no.sgl 56991. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 24 jul 1980 Entregado el 28 jul 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land at the rear of birling road, tunbridge wells kent. (Nos 23-30 birling rd.) Title no. K 498489. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 25 sept 1978 Entregado el 02 oct 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land adjoining 14 castle street ongar essex. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0