CLOUDSURE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CLOUDSURE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01420136 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CLOUDSURE LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CLOUDSURE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Lindred House 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLOUDSURE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SERVO COMPUTER SERVICES LIMITED | 18 oct 2006 | 18 oct 2006 |
| SERVO COMPUTER SERVICES PLC | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| DOWERBOND LIMITED | 16 may 1979 | 16 may 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CLOUDSURE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLOUDSURE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Lewis Mcglennon el 30 nov 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Philip Thompson como director el 12 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed servo computer services LIMITED\certificate issued on 04/11/21 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 ene 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Notification de Daisy Telecoms Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 jul 2019 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Daisy It Managed Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 jul 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Modification des détails de Daisy It Managed Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 abr 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Daisy House, Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR England a Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR el 29 abr 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nathan Richard Marke como director el 01 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Lewis Mcglennon como secretario el 01 feb 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2018 | 16 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CLOUDSURE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGLENNON, David Lewis | Director | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | 181536600002 | |||||
| SMITH, Stephen Alan | Director | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | 161471940001 | |||||
| THOMPSON, Neil Philip | Director | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | England | British | 158049040002 | |||||
| BADGER, Nicholas | Secretario | 50 Wyvern Gardens Dore S17 3PR Sheffield South Yorkshire | British | 18158340002 | ||||||
| MARTIN, William Thomas | Secretario | Weavers Wainhill OX39 4AB Chinnor Oxfordshire | British | 57302660001 | ||||||
| MCGLENNON, David Lewis | Secretario | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | 199438630001 | |||||||
| STOKES, Reeta | Secretario | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | 173997430001 | |||||||
| TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes | Secretario | The Lakes Bedford Road NN4 7HD Northampton Lakeside House Northamptonshire England | 179707420001 | |||||||
| WRAGG, Keith | Secretario | 80 Slayley View Road Barlborough S43 4WU Chesterfield Derbyshire | British | 50768630002 | ||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Director | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||
| BADGER, Nicholas | Director | 50 Wyvern Gardens Dore S17 3PR Sheffield South Yorkshire | British | 18158340002 | ||||||
| BADGER, Nicholas | Director | 50 Wyvern Gardens Dore S17 3PR Sheffield South Yorkshire | British | 18158340002 | ||||||
| BERTRAM, Peter Michael | Director | Torrells Pursers Lane Peaslake GU5 9RE Guildford Surrey | England | British | 52852920002 | |||||
| BILLING, Roger Stephen | Director | Belgrave House Belgrave Drive S10 3LQ Sheffield South Yorkshire | British | 66939500001 | ||||||
| BODILL, Timothy John | Director | Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton-On-Trent 16 Staffordshire United Kingdom | England | British | 140942610001 | |||||
| BURROWS, Nigel | Director | Greystone Head Kirkby Moor Road Kirkby Malzeard HG4 3RU Ripon N Yorks | British | 35683460001 | ||||||
| CLUTTON, Steven | Director | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 158222570001 | |||||
| COURTLEY, David John | Director | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 141213480001 | |||||
| FARROW, Matthew James | Director | 34 Lychgate Close LE10 2ES Burbage Leicestershire | England | British | 194105960001 | |||||
| HOWARTH, Mark Edward John | Director | 8 Parsons Grove Denby Village DE5 8PY Ripley Derbyshire | British | 79403870001 | ||||||
| JACKSON, Peter Daniel | Director | The Orchard Main Street Heath S44 5SA Chesterfield Derbyshire | British | 23515580002 | ||||||
| JONES, David Emrys | Director | Biggin House Biggin By Hulland DE6 3FJ Ashbourne Derbyshire | England | English | 211566200001 | |||||
| LLOYD, Neil Anthony | Director | 7 Kenwyn Road SW20 8TR London | England | British | 181988860001 | |||||
| LOCKWOOD, Robert John Harry | Director | 37 The Mount Wrenthorpe WF2 0NZ Wakefield West Yorkshire | British | 111070890001 | ||||||
| MARKE, Nathan Richard | Director | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | United Kingdom | British | 194292450001 | |||||
| MARTIN, William Thomas | Director | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 57302660001 | |||||
| MOAKES, Philip | Director | Hall Cliffe Cottage Back Lane, Warslow SK17 0JL Buxton Derbyshire | England | British | 94198370001 | |||||
| MULLER, Neil Keith | Director | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | England | British | 252490400001 | |||||
| PODMORE, Victor Gerald | Director | 12 Middlefield Drive Great Finborough IP14 3AH Stowmarket Suffolk | British | 15200080001 | ||||||
| RILEY, Matthew Robinson | Director | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | United Kingdom | British | 178585250001 | |||||
| ROBINSON, Nicholas John | Director | Ferry Nab Lane SL7 2EZ Medmanham Ferry Nab England United Kingdom | United Kingdom | British | 54873290006 | |||||
| ROBINSON, Nicholas | Director | 1 Wethered Road SL7 2BH Marlow Buckinghamshire | British | 54873290005 | ||||||
| ROBINSON, Nicholas | Director | 1 Wethered Road SL7 2BH Marlow Buckinghamshire | British | 54873290005 | ||||||
| SIMPSON, David Alan | Director | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | England | British | 80817560001 | |||||
| SMITH, William Joe | Director | Belstead Old Rectory Copdock IP8 3JS Ipswich Suffolk | England | British | 20327120001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CLOUDSURE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisy Telecoms Limited | 12 jul 2019 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Daisy It Managed Services Limited | 06 abr 2016 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CLOUDSURE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 25 oct 2001 Entregado el 07 nov 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 19 ago 1994 Entregado el 05 sept 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed charge supplemental to a debenture | Creado el 19 ago 1994 Entregado el 05 sept 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a debenture of even date | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 30 jun 1994 Entregado el 06 jul 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Servo house bakewell road darley dale matlock derbyshire t/nody 246529. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 31 mar 1992 Entregado el 13 abr 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Servo house, littlemoor, eckington, sheffield, N.E.derbyshire. T/no.DY151593 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 24 ago 1987 Entregado el 02 sept 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £210,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Breve descripción F/H the drill hall, littlemoor, echington, derbyshire. Title no dy 151593. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 30 nov 1982 Entregado el 09 dic 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 07 ene 1981 Entregado el 14 ene 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/Hold 6/10 sheffield road, dronfield, derbyshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0