YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02066471 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| UPPERMINOR LIMITED | 22 oct 1986 | 22 oct 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 6 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 jun 2018 | 6 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Modification des détails de Tilney Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 ene 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Modification des détails de Tilney Bestinvest Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 dic 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a 15 Canada Square London E14 5GL el 18 jul 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF England a 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 abr 2017 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Robert Porteous como director el 28 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Wadham St.John Downing como director el 21 feb 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL el 02 nov 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Rehana Hasan como secretario el 31 oct 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jacqueline Anne Gregory como secretario el 31 oct 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Alan Devey como director el 29 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Vernon Wright como director el 30 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Jacqueline Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL el 31 mar 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 2 páginas | AUD | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2016 au 31 dic 2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASAN, Rehana | Secretario | Canada Square E14 5GL London 15 | 217676460001 | |||||||
| DOWNING, Wadham St. John | Director | Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House England England | England | British | 203301710001 | |||||
| BELLAMY, Martin William | Secretario | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | 173986860001 | |||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Secretario | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | 197500790001 | |||||||
| HERON, Hugh | Secretario | 114 Carleton Road WF8 3NQ Pontefract West Yorkshire | British | 26428410003 | ||||||
| JOHNSTON, Carol Ann | Secretario | 9i Calles Las Palmeras Urb Vista Laguna 11312 Torreguadiaro Cadiz Spain | British | 52538020003 | ||||||
| NICHOLS, Sarah | Secretario | Lisbon Square LS1 4LY Leeds 8 West Yorkshire United Kingdom | British | 157100100001 | ||||||
| PEACOCK, Natasha Valerie | Secretario | Pear Tree Drive SK15 2PY Stalybridge 7 Cheshire | British | 129803720001 | ||||||
| BRADSHAW, Phillip Gordon | Director | Springfield Farm Hardwick Road East Hardwick WF8 3DL Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 26428400002 | |||||
| BUSSEY, Michael Adrian | Director | Ropergate House 43 Ropergate WF8 1JY Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 52554700003 | |||||
| CHAPMAN, Andrew | Director | Ask House 88 Leeds Road Bramhope LS16 9AN Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 39777190002 | |||||
| COLEMAN, Lynn Rose | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | United Kingdom | British | 149721950001 | |||||
| COONEY, Dominic Francis | Director | The Spinney WF2 6JN Wakefield 15 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 138563720001 | |||||
| CRESSWELL-TURNER, Miles Marius | Director | Ropergate House 43 Ropergate WF8 1JY Pontefract West Yorkshire | England | British | 135272850001 | |||||
| DEVEY, Robert Alan | Director | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 146956760001 | |||||
| FLOWER, Gordon Mark | Director | Sovereign Fold HG5 0WJ Knaresborough 4 North Yorkshire United Kingdom | England | British | 133025980001 | |||||
| FOX, Chay Munro | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | United Kingdom | British | 172112550001 | |||||
| HAINES, Stephen Paul | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 185462290001 | |||||
| HERON, Hugh | Director | 114 Carleton Road WF8 3NQ Pontefract West Yorkshire | England | British | 26428410003 | |||||
| HOGG, Andrew | Director | 1 Park House Mill Renton Close Bishop Monkton HG3 1BW Harrogate North Yorkshire | England | British | 63356910007 | |||||
| JACOBS, Andrew Stephen | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | United Kingdom | British | 183659460001 | |||||
| JOHNSTON, Carol Ann | Director | Brindley House Valley Road Killamarsh S21 1JB Sheffield | British | 52538020002 | ||||||
| JONES, Gaius Trefor Griffith | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 57884740001 | |||||
| JONES, Peter Francis | Director | 15 Wigton Park Close LS17 8UH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 33965180002 | |||||
| MIDGLEY, Steven Richard | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | England | British | 186658380001 | |||||
| MULLORD, Kathleen Francis | Director | Ropergate House 43 Ropergate WF8 1JY Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | South African | 160087800001 | |||||
| NICHOLS, Sarah Elizabeth | Director | 1 Home Farm Square Birstwith HG3 2WA Harrogate North Yorkshire | England | British | 93464600001 | |||||
| PEACOCK, Natasha Valerie | Director | Pear Tree Drive SK15 2PY Stalybridge 7 Cheshire | England | British | 129803720001 | |||||
| POLIN, Jonathan Charles | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | Scotland | British | 97840060003 | |||||
| PORTEOUS, John Robert | Director | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 166212270001 | |||||
| SAWYER, Gareth Matthew | Director | 5 Chelmsford Road HG1 5NA Harrogate | United Kingdom | British | 46468670003 | |||||
| SUMMERELL, Paul | Director | 11 Cricketers Fold Shadwell LS17 8WE Leeds West Yorkshire | British | 96162090001 | ||||||
| TAGLIABUE, Alfio | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | United Kingdom | Italian | 76352220004 | |||||
| WRIGHT, Paul Vernon | Director | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 137936580001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilney Bestinvest Group Limited | 06 abr 2016 | 17th Floor 6 New Street Square, New Fetter Lane EC4A 3BF London Towry Group England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of debts by way of security | Creado el 30 mar 2007 Entregado el 19 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All future rights title and interest and benefits in the debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over cash deposit | Creado el 30 mar 2007 Entregado el 16 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The deposit and all the present and future rights titles and benefit of the company in the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignment of debts by way of security | Creado el 29 sept 2004 Entregado el 15 oct 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or yorkshire investment group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción First priority assignment all present and future rights,titles and interest in and benefits of the company in the debts,together with the benefit of any and all intermediary contracts or agency agreements. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 02 oct 2002 Entregado el 17 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture deed | Creado el 28 feb 2001 Entregado el 06 mar 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0