YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED

YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaYORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02066471
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    UPPERMINOR LIMITED22 oct 198622 oct 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 jun 2018

    6 páginasLIQ03

    Modification des détails de Tilney Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 ene 2017

    2 páginasPSC05

    Modification des détails de Tilney Bestinvest Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 dic 2016

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a 15 Canada Square London E14 5GL el 18 jul 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 21 jun 2017

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF England a 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ

    1 páginasAD02

    Declaración de confirmación presentada el 06 abr 2017 con actualizaciones

    7 páginasCS01

    Cese del nombramiento de John Robert Porteous como director el 28 feb 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Wadham St.John Downing como director el 21 feb 2017

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL el 02 nov 2016

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mrs Rehana Hasan como secretario el 31 oct 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jacqueline Anne Gregory como secretario el 31 oct 2016

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    14 páginasAA

    Cese del nombramiento de Robert Alan Devey como director el 29 jul 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Vernon Wright como director el 30 jun 2016

    1 páginasTM01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL

    1 páginasAD04

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF

    1 páginasAD03

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital31 mar 2016

    Estado de capital el 31 mar 2016

    • Capital: GBP 5,000
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Jacqueline Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL el 31 mar 2016

    1 páginasAD01

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2016 au 31 dic 2015

    1 páginasAA01

    ¿Quiénes son los directivos de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HASAN, Rehana
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Secretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    217676460001
    DOWNING, Wadham St. John
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    England
    Director
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    England
    EnglandBritish203301710001
    BELLAMY, Martin William
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Secretario
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    173986860001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Secretario
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    197500790001
    HERON, Hugh
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secretario
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    British26428410003
    JOHNSTON, Carol Ann
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    Secretario
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    British52538020003
    NICHOLS, Sarah
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    United Kingdom
    British157100100001
    PEACOCK, Natasha Valerie
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    Secretario
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    British129803720001
    BRADSHAW, Phillip Gordon
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish26428400002
    BUSSEY, Michael Adrian
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish52554700003
    CHAPMAN, Andrew
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish39777190002
    COLEMAN, Lynn Rose
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Director
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomBritish149721950001
    COONEY, Dominic Francis
    The Spinney
    WF2 6JN Wakefield
    15
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    The Spinney
    WF2 6JN Wakefield
    15
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish138563720001
    CRESSWELL-TURNER, Miles Marius
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish135272850001
    DEVEY, Robert Alan
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Director
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish146956760001
    FLOWER, Gordon Mark
    Sovereign Fold
    HG5 0WJ Knaresborough
    4
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Sovereign Fold
    HG5 0WJ Knaresborough
    4
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish133025980001
    FOX, Chay Munro
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Director
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomBritish172112550001
    HAINES, Stephen Paul
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Director
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    EnglandBritish185462290001
    HERON, Hugh
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish26428410003
    HOGG, Andrew
    1 Park House Mill
    Renton Close Bishop Monkton
    HG3 1BW Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    1 Park House Mill
    Renton Close Bishop Monkton
    HG3 1BW Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish63356910007
    JACOBS, Andrew Stephen
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Director
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomBritish183659460001
    JOHNSTON, Carol Ann
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    Director
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    British52538020002
    JONES, Gaius Trefor Griffith
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Director
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    EnglandBritish57884740001
    JONES, Peter Francis
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    Director
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish33965180002
    MIDGLEY, Steven Richard
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Director
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    EnglandBritish186658380001
    MULLORD, Kathleen Francis
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomSouth African160087800001
    NICHOLS, Sarah Elizabeth
    1 Home Farm Square
    Birstwith
    HG3 2WA Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    1 Home Farm Square
    Birstwith
    HG3 2WA Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish93464600001
    PEACOCK, Natasha Valerie
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    Director
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    EnglandBritish129803720001
    POLIN, Jonathan Charles
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Director
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    ScotlandBritish97840060003
    PORTEOUS, John Robert
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Director
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish166212270001
    SAWYER, Gareth Matthew
    5 Chelmsford Road
    HG1 5NA Harrogate
    Director
    5 Chelmsford Road
    HG1 5NA Harrogate
    United KingdomBritish46468670003
    SUMMERELL, Paul
    11 Cricketers Fold
    Shadwell
    LS17 8WE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    11 Cricketers Fold
    Shadwell
    LS17 8WE Leeds
    West Yorkshire
    British96162090001
    TAGLIABUE, Alfio
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Director
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomItalian76352220004
    WRIGHT, Paul Vernon
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Director
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish137936580001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    17th Floor
    6 New Street Square, New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    Towry Group
    England
    England
    06 abr 2016
    17th Floor
    6 New Street Square, New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    Towry Group
    England
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04126418
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment of debts by way of security
    Creado el 30 mar 2007
    Entregado el 19 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All future rights title and interest and benefits in the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 13 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over cash deposit
    Creado el 30 mar 2007
    Entregado el 16 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit and all the present and future rights titles and benefit of the company in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 13 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Assignment of debts by way of security
    Creado el 29 sept 2004
    Entregado el 15 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or yorkshire investment group limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First priority assignment all present and future rights,titles and interest in and benefits of the company in the debts,together with the benefit of any and all intermediary contracts or agency agreements.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 22 ene 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 oct 2002
    Entregado el 17 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture deed
    Creado el 28 feb 2001
    Entregado el 06 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 06 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 08 ene 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    02 mar 2019Fecha de disolución
    21 jun 2017Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0