UTILITY TECHNOLOGY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | UTILITY TECHNOLOGY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02066658 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de UTILITY TECHNOLOGY LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra UTILITY TECHNOLOGY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Freedom House 3 Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UTILITY TECHNOLOGY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GILLOBELL LIMITED | 22 oct 1986 | 22 oct 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de UTILITY TECHNOLOGY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para UTILITY TECHNOLOGY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 7 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jun 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de The Freedom Group of Companies Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ashwood Court Springwood Way Tytherington Business Park Macclesfield Cheshire SK10 2XF a Freedom House 3 Red Hall Avenue Wakefield WF1 2UL el 07 abr 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Christopher Humphreys como director el 06 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Lee Cruddace como director el 06 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Christopher Humphreys como secretario el 06 dic 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Darrell Fox como director el 06 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Darrell Fox como secretario el 06 dic 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Perkins como director el 06 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2015 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2014 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Julie Downman como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Hertsmere House Shenley Road Borehamwood Hertfordshire WD6 1TE United Kingdom* el 03 dic 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Christopher Humphreys como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Owens como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de UTILITY TECHNOLOGY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX, Darrell | Secretario | 3 Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Freedom House England | 220941750001 | |||||||
| FOX, Darrell | Director | 3 Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Freedom House England | England | British | 56378250001 | |||||
| PERKINS, Mark | Director | 3 Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Freedom House England | United Kingdom | British | 85890200002 | |||||
| HULL, John Edward | Secretario | 7 Lakeside Close Perry PE28 0DX Huntingdon Cambridgeshire | British | 13501710001 | ||||||
| HUMPHREYS, David Christopher | Secretario | Springwood Way Tytherington Business Park SK10 2XF Macclesfield Ashwood Court Cheshire England | 173811500001 | |||||||
| JOHNSTONE, Lee | Secretario | Muberry Way Northowram HX3 7WJ Halifax 16 United Kingdom | 162237940001 | |||||||
| JOHNSTONE, Lee | Secretario | 16 Mulberry Way Northowram HX3 7WJ Halifax West Yorkshire | British | 105435350001 | ||||||
| MORTON, Julia Alison | Secretario | Kingsdown Close Wychwood Park CW2 5FX Weston 5 Cheshire | British | 141157110001 | ||||||
| O'SULLIVAN, Liam | Secretario | Shenley Road WD6 1TE Borehamwood Hertsmere House Hertfordshire United Kingdom | 165877890001 | |||||||
| WRIGHT, Michael Edward | Secretario | 31 St. Mary's Lynholm Road BN26 6JZ Polegate East Sussex | British | 13501720002 | ||||||
| ATKINSON, Mandy Elizabeth | Director | Victoria Road Morley LS27 7PA Leeds Wellfield House West Yorkshire | England | British | 179886360001 | |||||
| BULLOCK, Mark William | Director | Hancocks Mount SL5 9PQ Ascot Lullingstone House United Kingdom | United Kingdom | British | 149698150001 | |||||
| CATCHPOLE, Andrew Phillip | Director | Victoria Road Morley LS27 7PA Leeds Wellfield House West Yorkshire | England | British | 109869720001 | |||||
| CRUDDACE, David Lee, Mr. | Director | Springwood Way Tytherington Business Park SK10 2XF Macclesfield Ashwood Court Cheshire England | England | British | 165544960001 | |||||
| DOWNMAN, Julie Helen | Director | Springwood Way Tytherington Business Park SK10 2XF Macclesfield Ashwood Court Cheshire England | England | British | 242317210001 | |||||
| HAYES, Wayne Jonathan | Director | Ashwood Main Street Wentworth CB6 3QG Ely Cambridgeshire | United Kingdom | British | 87832860002 | |||||
| HULL, John Edward | Director | 17 Green End Road PE19 1SE St Neots Cambridgeshire | British | 13501710002 | ||||||
| HUMPHREYS, David Christopher | Director | Springwood Way Tytherington Business Park SK10 2XF Macclesfield Ashwood Court Cheshire England | United Kingdom | British | 117192120002 | |||||
| JOHNSTONE, Lee | Director | Victoria Road Morley LS27 7PA Leeds Wellfield House United Kingdom | United Kingdom | British | 158050450001 | |||||
| OWENS, David William | Director | Shenley Road WD6 1TE Borehamwood Hertsmere House Hertfordshire United Kingdom | England | British | 110731260001 | |||||
| RIGBY, William Simon | Director | Springwood Scotchman Lane Morley LS27 0NZ Leeds Yorkshire | United Kingdom | British | 48515290001 | |||||
| SPOONER, Richard Charles | Director | Cornstowe House 46 Oak Avenue South Wootton PE30 3JQ Kings Lynn Norfolk | England | British | 71774690001 | |||||
| TATE, Wendy | Director | 13 Greenway SK9 1LU Wilmslow Eden House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 103094250002 | |||||
| WRIGHT, Michael Edward | Director | 31 St. Mary's Lynholm Road BN26 6JZ Polegate East Sussex | British | 13501720002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de UTILITY TECHNOLOGY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Freedom Group Of Companies Limited | 06 abr 2016 | Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene UTILITY TECHNOLOGY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 23 mar 1990 Entregado el 02 abr 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 38A high street, st. Neots, cambridgeshire. Title no: cb 70486. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 19 ago 1987 Entregado el 26 ago 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene UTILITY TECHNOLOGY LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0