KINGS HORTICULTURE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KINGS HORTICULTURE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02201419 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KINGS HORTICULTURE LIMITED?
- Actividades de apoyo a la producción de cultivos (01610) / Agricultura, silvicultura y pesca
¿Dónde se encuentra KINGS HORTICULTURE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Station Road Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Gloucestershire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KINGS HORTICULTURE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 jul 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 abr 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 jul 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para KINGS HORTICULTURE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 22 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 05 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KINGS HORTICULTURE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2024 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Spencer Gareth Evans como director el 30 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2023 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2022 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Robert Emile Beeney el 23 mar 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2021 | 19 páginas | AA | ||
Notification de Origin Enterprises Public Limited Company en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 dic 2020 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Willmot Pertwee Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 dic 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2020 | 9 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Ronan Andrew Hughes como director el 11 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de James Marshall Rennie como director el 11 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Stephen Matthews como director el 11 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Robert Emile Beeney como director el 11 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2019 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2018 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr James Marshall Rennie como director el 20 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2017 | 8 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de KINGS HORTICULTURE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEENEY, Robert Emile | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | England | British | 132798690004 | |||||
| BRENNAN, Thomas Patrick | Secretario | 1 Penrwyn Court PE19 2SU St Neots Cambridgeshire | British | 202542640001 | ||||||
| BYFORD, Peter Derik | Secretario | Parkwood New Road Mistley CO11 2AG Manningtree Essex | British | 27852850001 | ||||||
| GORE, Malcolm Raymond | Secretario | 3 Branksome Way HA3 9SH Harrow Middlesex | British | 22648660001 | ||||||
| MURRAY, David Souter | Secretario | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | 164580360001 | |||||||
| SHARP, Barry John | Secretario | The Old Orchard Bekesbourne Lane Bekesbourne CT4 5DY Canterbury Kent | British | 35545820002 | ||||||
| WRIGHT, William Bernard | Secretario | 11 Tillingham Way N12 7EN London | British | 487670001 | ||||||
| RB SECRETARIAT LIMITED | Secretario corporativo | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 38862050001 | |||||||
| BOLDING, Jay Douglas | Director | 3325 North 134 Circle Omaha Nebraska 68164 Usa | American | 65252730002 | ||||||
| BOWLEY, Mark Oliver Ockleston | Director | 1 Margaret Cottage Langley Upper Green Saffron Waldon Essex | British | 29170960002 | ||||||
| BROWN, Richard | Director | Manor Farmhouse Manor Farm, Eddlethorpe YO17 9QT Malton North Yorkshire | United Kingdom | British | 111686890001 | |||||
| BYFORD, Peter Derik | Director | Parkwood New Road Mistley CO11 2AG Manningtree Essex | British | 27852850001 | ||||||
| DERBYSHIRE, Stephen | Director | The Gables Pump Lane, Fenton NG23 5DF Newark Nottinghamshire | England | British | 64532980001 | |||||
| DIFONZO, Kenneth Wayne | Director | 16646 Howard Circle Omaha 68118 Nebraska Usa | Us Citizen | 40453120001 | ||||||
| DOUGLAS, Ian Mayall | Director | Cherrytrees Paxton TD15 1TE Berwick Upon Tweed Northumberland | United Kingdom | British | 38712200001 | |||||
| DOWNIE, David Stewart | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | England | British | 101857040001 | |||||
| EVANS, Spencer Gareth | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | England | British | 227570820001 | |||||
| FARRELLY, Barry Brenden | Director | 38 The Grove RM14 2ET Upminster Essex | United Kingdom | British | 1243520001 | |||||
| FORGIE, Douglas Cameron | Director | 33 Warwick Road CM23 5NH Bishops Stortford Hertfordshire | British | 57495840001 | ||||||
| HEBARD, Andrew Bruce | Director | 135 Rosedown Court Winston Salem 27106 North Carolina Usa | British | 95957950001 | ||||||
| HECKMAN, Gregory Allen | Director | 6711 Davenport Street Omaha Nebraska 681342 Usa | American | 90638610004 | ||||||
| HUGHES, Ronan Andrew | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | Irish | 164466890001 | |||||
| JOHNSON, Owen Charles | Director | 1117 South 113th Court Omaha Nebraska 68144 U S A | U S Citizen | 98512790001 | ||||||
| MATTHEWS, Christopher Stephen | Director | Dale Farm Collingham Road LN6 9JB Swinderby Lincolnshire | England | British | 104573600001 | |||||
| MCKINNERNEY, Floyd | Director | 9309 Fm 462 North Hondo Texas 78861 Usa | American | 48604900002 | ||||||
| MESSEL, Scott Edward | Director | 1124 South 113th Court Omaha Nebraska 68144 U S A | Usa | U S Citizen | 98512890001 | |||||
| MURRAY, David | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | British | 25241430001 | |||||
| NICHOLLS, Alan Francis | Director | Broom Lodge High Garrett CM7 5NU Braintree Essex | British | 14088950001 | ||||||
| NICHOLLS, Francis Hugh | Director | Sheepcotes 6 Church Green Coggeshall CO6 1UD Colchester Essex | United Kingdom | British | 226380001 | |||||
| O'DONNELL, James Patrick | Director | 1126 S 181 Plaza Omaha Nebraska 68130 Usa | Us Citizen | 57520090002 | ||||||
| PALMER, Mervyn Roland | Director | The Forge Lower Road Hemingstone IP6 9RT Ipswich Suffolk | British | 29170970001 | ||||||
| PRIESTLEY, Richard Paul | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | United Kingdom | British | 138721210001 | |||||
| RENNIE, James Marshall | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | United Kingdom | British | 245275770001 | |||||
| RICHARD, Ralph Henry | Director | 28 Ringwood Avenue N2 9NS London | British | 11632560001 | ||||||
| ROBERTS, Jamie | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | British | 176036360001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KINGS HORTICULTURE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origin Enterprises Public Limited Company | 03 dic 2020 | Riverwalk Citywest Business Campus D24 DCW0 Dublin 24 4-6 Ireland Ireland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Willmot Pertwee Limited | 06 abr 2016 | Station Road Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Agrii England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0