PADARN POWER COMPANY LIMITED

PADARN POWER COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPADARN POWER COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02577647
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PADARN POWER COMPANY LIMITED?

    • Producción de electricidad (35110) / Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

    ¿Dónde se encuentra PADARN POWER COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    7 St James's Gardens
    W11 4RB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PADARN POWER COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SUREAGENT LIMITED28 ene 199128 ene 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PADARN POWER COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PADARN POWER COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr David Paul Tilstone el 16 jun 2012

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 28 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 feb 2012

    Estado de capital el 20 feb 2012

    • Capital: GBP 175,000
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ene 2011

    5 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2011 au 31 ene 2011

    3 páginasAA01

    Cambio de datos del secretario James Robert Mckellar el 28 mar 2011

    3 páginasCH03

    Cambio de datos del director James Robert Mckellar el 28 mar 2011

    4 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de 31 Serlby Court Somerset Square London W14 8EF el 08 abr 2011

    2 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 28 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Nicholas Simon Curtis el 10 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2009

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2008

    7 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    12 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PADARN POWER COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCKELLAR, James Robert
    St James's Gardens
    W11 4RB London
    7
    Secretario
    St James's Gardens
    W11 4RB London
    7
    British66732120001
    CURTIS, Nicholas Simon
    2 Saint Barnabas Villas
    Stockwell
    SW8 2EH London
    Director
    2 Saint Barnabas Villas
    Stockwell
    SW8 2EH London
    United KingdomBritish75334550001
    MCKELLAR, James Robert
    St James's Gardens
    W11 4RB London
    7
    Director
    St James's Gardens
    W11 4RB London
    7
    EnglandBritish66732120002
    BOYCE, Crispin John
    125 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3ES Bristol
    Avon
    Secretario
    125 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3ES Bristol
    Avon
    British5620950001
    BOYCE, Crispin John
    125 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3ES Bristol
    Avon
    Secretario
    125 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3ES Bristol
    Avon
    British5620950001
    DEVERSON, David Leonard
    3 Lockwood Street
    YO25 6RU Driffield
    East Yorkshire
    Secretario
    3 Lockwood Street
    YO25 6RU Driffield
    East Yorkshire
    British4826530001
    HELPS, Annabelle Penney
    112 Cromwell Tower
    Barbican
    EC2Y 8DD London
    Secretario
    112 Cromwell Tower
    Barbican
    EC2Y 8DD London
    Australian81687520005
    MCINNES, Charles Malcolm
    20 Willoughby Close
    Alveston
    BS35 3RW Bristol
    Secretario
    20 Willoughby Close
    Alveston
    BS35 3RW Bristol
    British81330480001
    MUIR, David Scott
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Secretario
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    British21883690003
    SHAW, Thomas Leslie, Dr
    The Old Vicarage
    Ston Easton
    BA3 4DN Bath
    Secretario
    The Old Vicarage
    Ston Easton
    BA3 4DN Bath
    British7428160001
    THOMAS, Richard Prichard
    Kiltynan
    St Davids Road
    LL55 1BH Caernarfon
    Gwynedd
    Secretario
    Kiltynan
    St Davids Road
    LL55 1BH Caernarfon
    Gwynedd
    British34290260001
    WILLIAMS, David James, Dr
    Steepholme
    Pen Y Lan Road
    NP10 8RW Newport
    Secretario
    Steepholme
    Pen Y Lan Road
    NP10 8RW Newport
    British155170640001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secretario corporativo
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secretario corporativo
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANTHONY, Paul
    Wentworth House
    St Leonards Hill
    SL4 4AT Windsor
    Berkshire
    Director
    Wentworth House
    St Leonards Hill
    SL4 4AT Windsor
    Berkshire
    British81406540001
    BOYCE, Crispin John
    125 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3ES Bristol
    Avon
    Director
    125 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3ES Bristol
    Avon
    British5620950001
    BOYCE, Crispin John
    125 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3ES Bristol
    Avon
    Director
    125 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3ES Bristol
    Avon
    British5620950001
    CHILTON, Malcolm David
    20 Prosper Meadow
    DY6 8BA Kingswinford
    West Midlands
    Director
    20 Prosper Meadow
    DY6 8BA Kingswinford
    West Midlands
    United KingdomBritish145829100001
    ELLIS, John Henry
    Tyn Llidiart
    Waunfawr
    LL55 3AG Caernarfon
    Gwynedd
    Director
    Tyn Llidiart
    Waunfawr
    LL55 3AG Caernarfon
    Gwynedd
    British41021070001
    GENT, Gerard Thomas
    7 Larch Close
    Langford
    BS18 7HF Bristol
    Avon
    Director
    7 Larch Close
    Langford
    BS18 7HF Bristol
    Avon
    British40782330001
    JONES, Alun Ffred
    Dolfelin Lon Dwr
    Llanllyfni
    LL54 6RP Caernarfon
    Gwynedd
    Cymru
    Director
    Dolfelin Lon Dwr
    Llanllyfni
    LL54 6RP Caernarfon
    Gwynedd
    Cymru
    WalesCymro20748530001
    KAY, Ian Andrew
    17 Jenner Street
    Seaforth
    New South Wales 2092
    Australia
    Director
    17 Jenner Street
    Seaforth
    New South Wales 2092
    Australia
    British102259090001
    KING, William John
    The Old Laundry
    Little Horwood
    MK17 0PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Laundry
    Little Horwood
    MK17 0PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish74570800001
    LAW, William Moran
    Ebenezer House Mill Hill
    Ellerker
    HU15 2DG Brough
    East Yorkshire
    Director
    Ebenezer House Mill Hill
    Ellerker
    HU15 2DG Brough
    East Yorkshire
    EnglandBritish4826540001
    MCDONALD, David Andrew
    Cherith
    Church Lane Chew Stoke
    BS40 8TU Bristol
    Avon
    Director
    Cherith
    Church Lane Chew Stoke
    BS40 8TU Bristol
    Avon
    EnglandBritish67201010001
    MUIR, David Scott
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    29 Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    UkBritish21883690003
    OWENS, David William
    The Garden House
    Marlow Bridge Lane
    SL7 1RH Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    The Garden House
    Marlow Bridge Lane
    SL7 1RH Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish110731260001
    SALISBURY, Eric Salvage
    Plas Rhosdican
    Ffordd Llanfaglan
    LL54 5RL Caernarfon
    Gwynned
    Director
    Plas Rhosdican
    Ffordd Llanfaglan
    LL54 5RL Caernarfon
    Gwynned
    WalesBritish2467670001
    SHAW, Thomas Leslie, Dr
    The Old Vicarage
    Ston Easton
    BA3 4DN Bath
    Director
    The Old Vicarage
    Ston Easton
    BA3 4DN Bath
    United KingdomBritish7428160001
    STANLEY, Martin Stephen William
    IP12
    Director
    IP12
    United KingdomBritish67692310003
    SWARBRICK, Gerard Joseph
    39 Upper Cranbrook Road
    Westbury Park
    BS6 7UR Bristol
    Director
    39 Upper Cranbrook Road
    Westbury Park
    BS6 7UR Bristol
    EnglandBritish27850210001
    TILSTONE, David Paul
    Ropemaker Place
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    C/O Macquarie Bank Limited
    United Kingdom
    Director
    Ropemaker Place
    28 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    C/O Macquarie Bank Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish117871440001
    WILKINSON, Edwin John
    Sheldon Lodge 5 Stone Lodge Walk
    IP2 9AP Ipswich
    Suffolk
    Director
    Sheldon Lodge 5 Stone Lodge Walk
    IP2 9AP Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish86926370001
    WILLIAMS, David James, Dr
    Steepholme
    Pen Y Lan Road
    NP10 8RW Newport
    Director
    Steepholme
    Pen Y Lan Road
    NP10 8RW Newport
    United KingdomBritish155170640001

    ¿Tiene PADARN POWER COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 18 mar 2005
    Entregado el 05 abr 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from meif renewable energy limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, goodwill & uncalled capital, investments, all monetary claims and related rights, insurance and related rights, all rights in relation to any assigned account floating charge all present and future assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • British Gas Trading Limited
    Transacciones
    • 05 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 18 nov 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Fixed and floating charge
    Creado el 24 jun 1993
    Entregado el 25 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0