HARTCLIFFE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | HARTCLIFFE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02582323 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HARTCLIFFE LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra HARTCLIFFE LIMITED?
Dirección de la sede social | I2 Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield Nottinghamshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HARTCLIFFE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SHADOWCALL LIMITED | 13 feb 1991 | 13 feb 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HARTCLIFFE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HARTCLIFFE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Bruce Middleton como secretario el 06 abr 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Donald William Borland como director el 06 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ciaran Anthony Kennedy como director el 25 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Shaun Allen Ormrod como director el 27 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David John Alexander Ritchie como director el 26 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Donald William Borland como director el 25 abr 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ciaran Anthony Kennedy el 05 may 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr David John Alexander Ritchie como director el 30 mar 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Eric Andrew Prescott como director el 30 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ciaran Anthony Kennedy como director el 23 jun 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Grant Findlay como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario Havelock Europa Plc el 18 mar 2013 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Unit 3 Swanwick Court Alfreton Derbyshire DE55 7AS* el 15 mar 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HARTCLIFFE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDLETON, Bruce | Secretario | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire | 245548680001 | |||||||||||
HAVELOCK EUROPA PLC | Secretario corporativo | Mansfield Hamilton Court NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire England |
| 52832210003 | ||||||||||
ORMROD, Shaun Allen | Director | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire | England | British | Ceo | 238467880001 | ||||||||
EMERY, Sheila Ann | Secretario | The Sands 3 Wichelstok Close SN1 4ES Swindon Wiltshire | British | Secretary | 11596210001 | |||||||||
MUNIESA, Julian | Secretario | 30 Quarry Road SN1 4EN Swindon Wilts | English | Financial Director | 33707640001 | |||||||||
CCS SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900001720001 | |||||||||||
ASLET, Peter Michael | Director | 26a Cammo Road EH4 8AP Edinburgh Midlothian | British | Financial Executive | 73615130004 | |||||||||
BALFOUR, Hew Edward Ogilvy | Director | Vicars Bridge Blairingone FK14 7NT Dollar The Mains Of Arndean Clackmannanshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 132405720001 | ||||||||
BORLAND, Donald William | Director | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 66010670002 | ||||||||
BUDD, Christopher George | Director | Bolivia Mount The Dhoor IM7 4ED Lazayre Isle Of Man | British | Company Director | 34221640003 | |||||||||
BURNS, Michael Christopher | Director | 12 Orchard Close Knightsbridge Court Winterbourne BS17 5BZ Bristol | British | Managing Director | 22451950002 | |||||||||
DE THORPE MILLARD, Brian Percival | Director | 4 Winders Hill Cottages Off Quarry Road Godstone Surrey | British | Managing Director | 71472600001 | |||||||||
DENNIS, Arthur | Director | Cleveland 114 Mancroft Road Caddington LU1 4EN Luton Bedfordshire | British | Company Director | 44628980001 | |||||||||
ELLIOTT, Peter Norman | Director | 8 Larch Road Kingswood BS15 4UQ Bristol Avon | British | Managing Director | 8591740001 | |||||||||
ELLIOTT, Peter Norman | Director | 8 Larch Road Kingswood BS15 4UQ Bristol Avon | British | Managing Director | 8591740001 | |||||||||
EMERY, Michael Leonard | Director | The Sands 3 Wichelstok Close SN1 4ES Swindon Wiltshire | British | Advertising Executive | 11596220001 | |||||||||
FINDLAY, Grant Mcdowall | Director | 114 Duchy Road HG1 2HB Harrogate North Yorkshire | England | British | Group Finance Director | 65759080002 | ||||||||
HUGHES, Philip John | Director | The Bungalow 241a Lower Way Thatcham RG19 3TP Newbury Berkshire | British | Financial Director | 16828910001 | |||||||||
JAMES, Terence Ivan | Director | 9 Belle Vue Road SN1 3HQ Swindon Wiltshire | British | Sales Director | 14970780001 | |||||||||
KENNEDY, Ciaran Anthony | Director | John Smith Business Park Grantsmuir Road KY2 6NA Kirkcaldy Havelock House Fife Scotland | Scotland | Northern Irish | Finance Director | 43853920003 | ||||||||
MACSPORRAN, Graham | Director | Rydal 103 Old Greenock Road PA7 5BB Bishopton Renfrewshire | British | Accountant | 71376370001 | |||||||||
MATTHEWS, Anthony | Director | The New House Main Street Compton Martin Bristol Avon | British | Works Director | 43954830001 | |||||||||
MUNIESA, Julian | Director | 44 Stafford Road St Werburghs BS2 9UN Bristol | English | Financial Director | 33707640002 | |||||||||
PRESCOTT, Eric Andrew | Director | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire England | England | British | Company Director | 154581430001 | ||||||||
RITCHIE, David John Alexander | Director | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire | Scotland | British | Director | 279706260001 | ||||||||
SCANNELL, Patrick John | Director | 20 Rugby Road Dunchurch CV22 6PN Rugby Warwickshire | British | Accountant | 8097790001 | |||||||||
THOMSON, George | Director | 14 Birch Grove SL4 5RT Windsor Berkshire | British | Business Development Director | 24638370001 | |||||||||
WEBSTER, John Strachan | Director | 7 Boclair Road Bearsden G61 2AE Glasgow Lanarkshire | British | Finance Director | 718070001 | |||||||||
CCS DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900001710001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HARTCLIFFE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havelock Europa Plc | 06 abr 2016 | Hamilton Court NG18 5FB Mansfield I2 Mansfield England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene HARTCLIFFE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creado el 28 sept 1995 Entregado el 06 oct 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a land and buildings at cater road bishopsworth bristol t/no: AV100051 by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge of whole | Creado el 28 sept 1995 Entregado el 03 oct 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £160,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Land and buildings on the south side of cater road bishopsworth bristol t/no: AV100051. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 27 sept 1995 Entregado el 11 oct 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a secured loan note 1995/1998 of £100,000 on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property at 11-16 cater road, bishopsworth, bristol and ground floor 4 high street, swindon wiltshire .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 27 sept 1995 Entregado el 29 sept 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage deed | Creado el 27 sept 1995 Entregado el 29 sept 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Sakuria auto printing press-serial no. RJ100393. William crossland punch-serial no.230/nk. Sias print serifast printing press-serial no.924228. Sias print serifast printing press-serial no.93287.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 02 oct 1991 Entregado el 21 oct 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Collateral debenture | Creado el 02 oct 1991 Entregado el 10 oct 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from mediumrent limited to the chargee under the terms of a secured loan note 1993/1996 of £150,000 | |
Breve descripción L/H property situate at 11-16 cater road, bishopsworth bristol, l/h property situate at ground floor, 4 high street, swindon, wilts.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rent deposit deed | Creado el 07 ago 1991 Entregado el 20 ago 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 29/3/83 and/or the deed | |
Breve descripción £10,000 in an account with national westminister bank PLC. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0