HARTCLIFFE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHARTCLIFFE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02582323
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HARTCLIFFE LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra HARTCLIFFE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    I2 Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    Nottinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HARTCLIFFE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SHADOWCALL LIMITED13 feb 199113 feb 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HARTCLIFFE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HARTCLIFFE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Nombramiento de Mr Bruce Middleton como secretario el 06 abr 2018

    2 páginasAP03
    X74AXLBC

    Cese del nombramiento de Donald William Borland como director el 06 abr 2018

    1 páginasTM01
    X74AX6T5

    Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X6LQY8MX

    Cese del nombramiento de Ciaran Anthony Kennedy como director el 25 abr 2017

    1 páginasTM01
    X6HVR6PL

    Nombramiento de Mr Shaun Allen Ormrod como director el 27 sept 2017

    2 páginasAP01
    X6HGODVS

    Cese del nombramiento de David John Alexander Ritchie como director el 26 sept 2017

    1 páginasTM01
    X6HGO8RE

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    3 páginasAA
    A6EXX0YZ

    Nombramiento de Mr Donald William Borland como director el 25 abr 2017

    2 páginasAP01
    X66MVEX6

    Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01
    X5MG4XUH

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    3 páginasAA
    A5F1UGJ6

    Déclaration annuelle établie au 20 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 ene 2016

    Estado de capital el 12 ene 2016

    • Capital: GBP 6,450
    SH01
    X4YF5JY4

    Cambio de datos del director Mr Ciaran Anthony Kennedy el 05 may 2015

    2 páginasCH01
    X4YF5JVT

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    3 páginasAA
    A4FIB43U

    Nombramiento de Mr David John Alexander Ritchie como director el 30 mar 2015

    2 páginasAP01
    X45DU8BM

    Cese del nombramiento de Eric Andrew Prescott como director el 30 mar 2015

    1 páginasTM01
    X45DU33C

    Déclaration annuelle établie au 20 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ene 2015

    Estado de capital el 06 ene 2015

    • Capital: GBP 6,450
    SH01
    X3YI9GUJ

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013

    3 páginasAA
    S3ERWTCP

    Nombramiento de Mr Ciaran Anthony Kennedy como director el 23 jun 2014

    2 páginasAP01
    X3E4JWNV

    Cese del nombramiento de Grant Findlay como director

    1 páginasTM01
    X3907ZCG

    Déclaration annuelle établie au 20 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 ene 2014

    Estado de capital el 14 ene 2014

    • Capital: GBP 6,450
    SH01
    X2ZJYHIO

    Cambio de datos del secretario Havelock Europa Plc el 18 mar 2013

    1 páginasCH04
    X2ZJYHIG

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    9 páginasAA
    X2GSIKSJ

    Domicilio social registrado cambiado de * Unit 3 Swanwick Court Alfreton Derbyshire DE55 7AS* el 15 mar 2013

    1 páginasAD01
    X247UG4A

    ¿Quiénes son los directivos de HARTCLIFFE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MIDDLETON, Bruce
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Secretario
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    245548680001
    HAVELOCK EUROPA PLC
    Mansfield
    Hamilton Court
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    England
    Secretario corporativo
    Mansfield
    Hamilton Court
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro782546
    52832210003
    ORMROD, Shaun Allen
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Director
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCeo238467880001
    EMERY, Sheila Ann
    The Sands 3 Wichelstok Close
    SN1 4ES Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    The Sands 3 Wichelstok Close
    SN1 4ES Swindon
    Wiltshire
    BritishSecretary11596210001
    MUNIESA, Julian
    30 Quarry Road
    SN1 4EN Swindon
    Wilts
    Secretario
    30 Quarry Road
    SN1 4EN Swindon
    Wilts
    EnglishFinancial Director33707640001
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    ASLET, Peter Michael
    26a Cammo Road
    EH4 8AP Edinburgh
    Midlothian
    Director
    26a Cammo Road
    EH4 8AP Edinburgh
    Midlothian
    BritishFinancial Executive73615130004
    BALFOUR, Hew Edward Ogilvy
    Vicars Bridge
    Blairingone
    FK14 7NT Dollar
    The Mains Of Arndean
    Clackmannanshire
    Director
    Vicars Bridge
    Blairingone
    FK14 7NT Dollar
    The Mains Of Arndean
    Clackmannanshire
    United KingdomBritishChief Executive132405720001
    BORLAND, Donald William
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Director
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer66010670002
    BUDD, Christopher George
    Bolivia Mount
    The Dhoor
    IM7 4ED Lazayre
    Isle Of Man
    Director
    Bolivia Mount
    The Dhoor
    IM7 4ED Lazayre
    Isle Of Man
    BritishCompany Director34221640003
    BURNS, Michael Christopher
    12 Orchard Close
    Knightsbridge Court Winterbourne
    BS17 5BZ Bristol
    Director
    12 Orchard Close
    Knightsbridge Court Winterbourne
    BS17 5BZ Bristol
    BritishManaging Director22451950002
    DE THORPE MILLARD, Brian Percival
    4 Winders Hill Cottages
    Off Quarry Road
    Godstone
    Surrey
    Director
    4 Winders Hill Cottages
    Off Quarry Road
    Godstone
    Surrey
    BritishManaging Director71472600001
    DENNIS, Arthur
    Cleveland 114 Mancroft Road
    Caddington
    LU1 4EN Luton
    Bedfordshire
    Director
    Cleveland 114 Mancroft Road
    Caddington
    LU1 4EN Luton
    Bedfordshire
    BritishCompany Director44628980001
    ELLIOTT, Peter Norman
    8 Larch Road
    Kingswood
    BS15 4UQ Bristol
    Avon
    Director
    8 Larch Road
    Kingswood
    BS15 4UQ Bristol
    Avon
    BritishManaging Director8591740001
    ELLIOTT, Peter Norman
    8 Larch Road
    Kingswood
    BS15 4UQ Bristol
    Avon
    Director
    8 Larch Road
    Kingswood
    BS15 4UQ Bristol
    Avon
    BritishManaging Director8591740001
    EMERY, Michael Leonard
    The Sands 3 Wichelstok Close
    SN1 4ES Swindon
    Wiltshire
    Director
    The Sands 3 Wichelstok Close
    SN1 4ES Swindon
    Wiltshire
    BritishAdvertising Executive11596220001
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishGroup Finance Director65759080002
    HUGHES, Philip John
    The Bungalow 241a Lower Way
    Thatcham
    RG19 3TP Newbury
    Berkshire
    Director
    The Bungalow 241a Lower Way
    Thatcham
    RG19 3TP Newbury
    Berkshire
    BritishFinancial Director16828910001
    JAMES, Terence Ivan
    9 Belle Vue Road
    SN1 3HQ Swindon
    Wiltshire
    Director
    9 Belle Vue Road
    SN1 3HQ Swindon
    Wiltshire
    BritishSales Director14970780001
    KENNEDY, Ciaran Anthony
    John Smith Business Park
    Grantsmuir Road
    KY2 6NA Kirkcaldy
    Havelock House
    Fife
    Scotland
    Director
    John Smith Business Park
    Grantsmuir Road
    KY2 6NA Kirkcaldy
    Havelock House
    Fife
    Scotland
    ScotlandNorthern IrishFinance Director43853920003
    MACSPORRAN, Graham
    Rydal 103 Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    Renfrewshire
    Director
    Rydal 103 Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    Renfrewshire
    BritishAccountant71376370001
    MATTHEWS, Anthony
    The New House
    Main Street Compton Martin
    Bristol
    Avon
    Director
    The New House
    Main Street Compton Martin
    Bristol
    Avon
    BritishWorks Director43954830001
    MUNIESA, Julian
    44 Stafford Road
    St Werburghs
    BS2 9UN Bristol
    Director
    44 Stafford Road
    St Werburghs
    BS2 9UN Bristol
    EnglishFinancial Director33707640002
    PRESCOTT, Eric Andrew
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    England
    Director
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    England
    EnglandBritishCompany Director154581430001
    RITCHIE, David John Alexander
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Director
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    ScotlandBritishDirector279706260001
    SCANNELL, Patrick John
    20 Rugby Road
    Dunchurch
    CV22 6PN Rugby
    Warwickshire
    Director
    20 Rugby Road
    Dunchurch
    CV22 6PN Rugby
    Warwickshire
    BritishAccountant8097790001
    THOMSON, George
    14 Birch Grove
    SL4 5RT Windsor
    Berkshire
    Director
    14 Birch Grove
    SL4 5RT Windsor
    Berkshire
    BritishBusiness Development Director24638370001
    WEBSTER, John Strachan
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Lanarkshire
    BritishFinance Director718070001
    CCS DIRECTORS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001710001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HARTCLIFFE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Hamilton Court
    NG18 5FB Mansfield
    I2 Mansfield
    England
    06 abr 2016
    Hamilton Court
    NG18 5FB Mansfield
    I2 Mansfield
    England
    No
    Forma jurídicaPlc
    País de registroEngland
    Autoridad legalEnglish Law
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00782546
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene HARTCLIFFE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 28 sept 1995
    Entregado el 06 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a land and buildings at cater road bishopsworth bristol t/no: AV100051 by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 06 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of whole
    Creado el 28 sept 1995
    Entregado el 03 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £160,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Land and buildings on the south side of cater road bishopsworth bristol t/no: AV100051.
    Personas con derecho
    • Somerfield Stores Limited
    Transacciones
    • 03 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 14 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 sept 1995
    Entregado el 11 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a secured loan note 1995/1998 of £100,000 on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property at 11-16 cater road, bishopsworth, bristol and ground floor 4 high street, swindon wiltshire .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Natwest Ventures Investments Limited
    Transacciones
    • 11 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 sept 1995
    Entregado el 29 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 29 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage deed
    Creado el 27 sept 1995
    Entregado el 29 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Sakuria auto printing press-serial no. RJ100393. William crossland punch-serial no.230/nk. Sias print serifast printing press-serial no.924228. Sias print serifast printing press-serial no.93287.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 29 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 02 oct 1991
    Entregado el 21 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 oct 1991Registro de una carga
    • 25 abr 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 02 oct 1991
    Entregado el 10 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from mediumrent limited to the chargee under the terms of a secured loan note 1993/1996 of £150,000
    Breve descripción
    L/H property situate at 11-16 cater road, bishopsworth bristol, l/h property situate at ground floor, 4 high street, swindon, wilts.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transacciones
    • 10 oct 1991Registro de una carga
    • 25 abr 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 07 ago 1991
    Entregado el 20 ago 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 29/3/83 and/or the deed
    Breve descripción
    £10,000 in an account with national westminister bank PLC.
    Personas con derecho
    • Hannick Homes and Developments Limited
    Transacciones
    • 20 ago 1991Registro de una carga
    • 12 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0