RM EDUCATIONAL RESOURCES LTD
Visión general
Nombre de la empresa | RM EDUCATIONAL RESOURCES LTD |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03100039 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RM EDUCATIONAL RESOURCES LTD?
- Comercio al por mayor no especializado (46900) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra RM EDUCATIONAL RESOURCES LTD?
Dirección de la sede social | 142b Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon Oxon England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RM EDUCATIONAL RESOURCES LTD?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
THE CONSORTIUM FOR PURCHASING AND DISTRIBUTION LIMITED | 20 oct 1995 | 20 oct 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RM EDUCATIONAL RESOURCES LTD?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 nov 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 31 ago 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 nov 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para RM EDUCATIONAL RESOURCES LTD?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 12 dic 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 26 dic 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 12 dic 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RM EDUCATIONAL RESOURCES LTD?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 12 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels modifiés établis au 30 nov 2023 | 48 páginas | AAMD | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2023 | 42 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Fattal como secretario el 03 jun 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2022 | 44 páginas | AA | ||||||||||
Declaraci ón de confirmación presentada el 12 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Monique Louis como director el 28 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Emmanuel Francois Walter como director el 08 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Michael Goodwin como director el 08 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Registro de la carga 031000390012, creada el 05 may 2023 | 75 páginas | MR01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 12 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 031000390011, creada el 29 mar 2023 | 75 páginas | MR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Cook como director el 20 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Jozsef Lagler como director el 23 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Emmanuel Francois Walter como director el 15 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Ian James Berry como director el 15 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2021 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 dic 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Thomas George Martin como director el 01 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cessation de Hedgelane Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 ago 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de Rm Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 ago 2021 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Ian James Berry como director el 01 jun 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2020 | 41 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RM EDUCATIONAL RESOURCES LTD?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATTAL, Daniel | Secretario | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | 323685230001 | |||||||
COOK, Mark | Director | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | Director | 154617450001 | ||||
GOODWIN, Simon Michael | Director | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | Director | 180053770001 | ||||
DAVIDSON-SHRINE, Gregory | Secretario | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | 234771780001 | |||||||
ELSEY, Robert David | Secretario | 7 Ravenscroft Gardens BA14 7JU Trowbridge Wiltshire | British | Company Director | 44433580001 | |||||
GAHAN, Michael William | Secretario | The Orchard Vinegar Hill NP26 3EJ Undy Gwent | British | Finance Director | 182707860001 | |||||
JARRETT, Susan Lynne | Secretario | 37 Bobbin Lane Westwood BA15 2DL Bradford On Avon Wiltshire | British | Finance Dir | 54448350001 | |||||
MARRINER, Stuart Steven | Secretario | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | 168621440001 | |||||||
STAFFORD, Robert Simeon | Secretario | 4 Clifton Wood Crescent Clifton Wood BS8 4TU Bristol | British | Director | 77214360002 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BARNETT, Mark William | Director | Old Meadows Farm Fowlswick Lane, Allington SN14 6LT Chippenham Wiltshire | England | British | Chief Operating Officer | 78407520002 | ||||
BAUERNFEIND, David Gregory | Director | Cherry Orchard North Kembrey Park SN2 8UH Swindon Rowan House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 99529910002 | ||||
BERRY, Mark Ian James | Director | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | English | Director | 283870750001 | ||||
BUNTING, Jonathan Michael | Director | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Director | 115232260002 | ||||
CADDELL, Joseph | Director | West Yatton Yatton Keynell SN14 7EW Chippenham Pond Cottage Wiltshire United Kingdom | England | British | Business Support Director | 115479170002 | ||||
CASHMORE, Mark Richard | Director | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Director | 115657470004 | ||||
COOK, Kevin Nigel | Director | 4 Sandcroft Avenue BS23 4SS Weston Super Mare North Somerset | British | Director | 86627710001 | |||||
CROOKES, Adrian | Director | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Accountant | 174571650001 | ||||
DAVIDSON-SHRINE, Gregory | Director | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Company Director | 169072790002 | ||||
DIXON, Nigel Anthony | Director | Manor Farm House SP4 0JZ Porton Wiltshire | England | British | Director | 92047990001 | ||||
ELSEY, Robert David | Director | 7 Ravenscroft Gardens BA14 7JU Trowbridge Wiltshire | United Kingdom | British | Company Director | 44433580001 | ||||
GAHAN, Michael William | Director | Cherry Orchard North Kembrey Park SN2 8UH Swindon Rowan House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 182707860001 | ||||
GEORGE, Dudley Robert Charles | Director | School Cottage Coaley GL11 5ED Dursley Gloucestershire | British | Company Director | 44433600001 | |||||
GOULD, Jeffrey Richard | Director | 4 Hobbs Hill Keevil BA14 6LR Trowbridge Wiltshire | British | Director | 45469620001 | |||||
GRESHAM, Nicholas John | Director | Cherry Orchard North Kembrey Park SN2 8UH Swindon Rowan House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 91773790002 | ||||
JARRETT, Susan Lynne | Director | 37 Bobbin Lane Westwood BA15 2DL Bradford On Avon Wiltshire | British | Director | 54448350001 | |||||
KERSHAW, John Graham Christopher | Director | Pipers Way SN3 1RF Swindon Wakefield House Wiltshire United Kingdom | England | British | Director | 165578560001 | ||||
LAGLER, Mark Jozsef | Director | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | United Kingdom | British | Solicitor | 227904200001 | ||||
LEECH, Glenn Peter | Director | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | United Kingdom | British | Managing Director | 131999190002 | ||||
LEGGETT, Simon Anthony | Director | Hammond Way Trowbridge BA14 8RR Wiltshire | United Kingdom | British | Sales & Marketing Director | 148603680001 | ||||
LEWENDON, Craig Stuart | Director | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Company Director | 234768920001 | ||||
LOUIS, Monique | Director | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | Managing Director | 238289490001 | ||||
MARTIN, Neil Thomas George | Director | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | United Kingdom | British | Company Director | 126681070006 | ||||
PALMER, Matthew James | Director | Pipers Way SN3 1RF Swindon Wakefield House Wiltshire United Kingdom | England | British | Sales Director | 149814290001 | ||||
POTTER, Brian Geoffrey | Director | Cote Bank 65a Bristol Road Lower BS23 2TL Weston Super Mare Somerset | British | Marketing & Sales Director | 72749380002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RM EDUCATIONAL RESOURCES LTD?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rm Plc | 04 ago 2021 | Park Drive Milton OX14 4SE Abingdon 142b England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Hedgelane Limited | 25 sept 2019 | Park Drive Milton OX14 4SE Abingdon 142b England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Hammond Bridge Limited | 06 abr 2016 | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0