LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03349330 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED?
Dirección de la sede social | Lower Ground Floor, Elsley House 24/30 Great Titchfield Street W1W 8BF London England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
PURE EXCELLENCE LIMITED | 10 abr 1997 | 10 abr 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 26 may 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cese del nombramiento de James Forrester Spragg como director el 31 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 1st Floor, 163 Eversholt Street London NW1 1BU England a Lower Ground Floor, Elsley House 24/30 Great Titchfield Street London W1W 8BF el 15 mar 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 may 2019 | 2 páginas | AA | ||
Registro de la carga 033493300010, creada el 14 ene 2020 | 24 páginas | MR01 | ||
Nombramiento de Mr Adrian Walker como director el 06 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Giles Matthew Oliver David como secretario el 06 dic 2019 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Giles Matthew Oliver David como director el 06 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr James Forrester Spragg como director el 30 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen Richards como director el 30 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 may 2018 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Registro de la carga 033493300009, creada el 15 ago 2018 | 25 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 033493300008, creada el 15 ago 2018 | 25 páginas | MR01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Notification de La Tasca Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 06 mar 2018 | 2 páginas | PSC09 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 may 2017 | 2 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Timothy John Doubleday como director el 21 jun 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Giles Matthew Oliver David como secretario el 21 jun 2017 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Timothy John Doubleday como secretario el 21 jun 2017 | 1 páginas | TM02 | ||
¿Quiénes son los directivos de LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALKER, Adrian Rowland | Director | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | England | British | Director, Cfo | 265227060001 | ||||||||
CHAPMAN, Jonathan Robert | Secretario | 95 Cyprus Street Stretford M32 8BE Manchester Lancashire | British | 49613260001 | ||||||||||
DAVID, Giles Matthew Oliver | Secretario | Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor, 163 England | 237559600001 | |||||||||||
DOUBLEDAY, Timothy John | Secretario | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | 201020470001 | |||||||||||
EVANS, Martin John | Secretario | 6 Bellcast Close Appleton WA4 5SA Warrington Cheshire | British | 52869850002 | ||||||||||
GATT, Neil Robert | Secretario | 12 Hill View Rise Winnington CW8 4XA Northwich Cheshire | British | Director | 24347400001 | |||||||||
POWELL, Matthew David | Secretario | 33 Tagg Wood View Ramsbottom BL0 9XP Bury Lancashire | British | Director | 125692100001 | |||||||||
MAZARS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London Tower United Kingdom |
| 130398850001 | ||||||||||
SNR DENTON SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Fleet Place EC4M 7WS London One | 98515470002 | |||||||||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||||||
BAKER, Suzanne Louise | Director | Lincoln House Rouse Court SL9 0NJ Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Company Director | 35409580006 | ||||||||
BARNES, Michael John | Director | 28 Old Lane Bramhope LS16 9AZ Leeds West Yorkshire | England | British | Company Director | 11951630001 | ||||||||
BROWN, Aaron Maxwell | Director | Elsworthy Terrace NW3 3DR London 5 | United Kingdom | British | Business Consultant | 98928830002 | ||||||||
DAVID, Giles Matthew Oliver | Director | Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor, 163 England | England | British | Accountant | 187907210001 | ||||||||
DEVLIN, Stephen | Director | Woodbine Cottage Plumley Moor Road, Plumley WA16 9SB Knutsford Cheshire | British | Solicitor | 64442260001 | |||||||||
DOUBLEDAY, Timothy John | Director | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 91011320001 | ||||||||
EVANS, Martin John | Director | 6 Bellcast Close Appleton WA4 5SA Warrington Cheshire | England | British | Finance Director | 52869850002 | ||||||||
FREEMAN, Roger | Director | 21 Warwick Drive Hale WA15 9EA Altrincham Cheshire | England | British | Executive Director | 119448440001 | ||||||||
GATT, Neil Robert | Director | Rode Street Farm Rode Street CW6 0EF Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | Managing Director | 24347400003 | ||||||||
HARMAN, Gordon | Director | Withinlee Cottage Within Lee Road Mottram SK10 4QE St Andrew Cheshire | British | Company Director | 102037580001 | |||||||||
HORLER, James Michael Alexander | Director | West End Farm Main Street WR11 7UE Sedgeberrow Worcestershire | British | Chief Executive | 65293140002 | |||||||||
KEEN, Christian | Director | The Paddock Alverton NG13 9PB Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 117424240001 | ||||||||
MCLAUGHLIN, Mary Catherine | Director | The Cobbles Donkey Lane SK9 1PX Wilmslow Cheshire | United Kingdom | Irish | Managing Director | 58320700002 | ||||||||
MYERS, David Paul | Director | 500 Capability Green LU1 3LS Luton Porter Tun House Bedfordshire United Kingdom | England | British | Director | 142171370001 | ||||||||
POWELL, Matthew David | Director | 33 Tagg Wood View Ramsbottom BL0 9XP Bury Lancashire | England | British | Director | 125692100001 | ||||||||
RICHARDS, Stephen | Director | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | England | British | Director | 187618040002 | ||||||||
SMALLEY, Timothy John | Director | Chivers Road CM15 0LG Stondon Massey Stondon Place Essex | United Kingdom | British | Director | 102593650002 | ||||||||
SPRAGG, James Forrester | Director | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 127602840002 | ||||||||
SYMONDS, Paul | Director | Willow House 10a Vicars Close, Biddenham MK40 4BG Bedford Bedfordshire | England | British | Director | 80167420001 | ||||||||
WILKINSON, Simon | Director | 500 Capability Green LU1 3LS Luton Porter Tun House Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 158424890001 | ||||||||
YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Tasca Group Limited | 06 abr 2016 | 163 Eversholt Street NW1 1BU London 1st Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
10 abr 2017 | 10 abr 2017 | La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene LA TASCA RESTAURANTS HOLDINGS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 14 ene 2020 Entregado el 16 ene 2020 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 15 ago 2018 Entregado el 23 ago 2018 | Pendiente | ||
Breve descripción None at the date of the charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 15 ago 2018 Entregado el 23 ago 2018 | Pendiente | ||
Breve descripción All current and future interests in property and intellectual property owned by the company, in each case as defined in the supplemental debenture registered by this form MR01. For more details please refer to the supplemental debenture. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 05 feb 2016 Entregado el 12 feb 2016 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 25 sept 2015 Entregado el 05 oct 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 25 sept 2015 Entregado el 02 oct 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 24 feb 2011 Entregado el 28 feb 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the parent and each obligor and bay restaurant holdings limited and la tasca, inc to the security trustee or to any of the other secured parties or any other finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 27 mar 2008 Entregado el 03 abr 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the parent and each obligor of la tasca, inc to the chargee or to any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 10 sept 2001 Entregado el 13 sept 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the finance parties and to the holders of the secured consideration loan notes under the secured consideration loan notes (as defined therein) on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 30 abr 1997 Entregado el 14 may 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0