DARAG INSURANCE UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DARAG INSURANCE UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03654581 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DARAG INSURANCE UK LIMITED?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra DARAG INSURANCE UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | 25 Eastcheap 4th Floor EC3M 1DT London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DARAG INSURANCE UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THE UNDERWRITER INSURANCE COMPANY LIMITED | 21 jul 1999 | 21 jul 1999 |
| THE UNDERWRITER COMPANY LIMITED | 19 oct 1998 | 19 oct 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DARAG INSURANCE UK LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DARAG INSURANCE UK LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 18 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 02 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 18 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DARAG INSURANCE UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 33 páginas | AA | ||
Memorándum y Estatutos | 22 páginas | MA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Theo James Rickus Wilkes como director el 01 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 33 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de James Christopher Paul Insley como director el 12 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Alexander Thomas Roth como director el 30 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Acumen Group Management Ltd como secretario el 01 may 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 14 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||
Notification de Aleph Capital Partners Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 may 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||
Modification des détails de Barry Stuart Volpert en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 may 2023 | 2 páginas | PSC04 | ||
Modification des détails de Mr Hugues Bernard Charles Lepic en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 may 2023 | 2 páginas | PSC04 | ||
Cessation de Aleph Capital Partners Llp en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Nombramiento de Mr James Christopher Paul Insley como director el 17 nov 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de James Christopher Paul Insley como director el 19 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr James Christopher Paul Insley como director el 19 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Simon James Cheal como director el 19 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Stuart Robert Davies como director el 15 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 33 páginas | AA | ||
Notification de Aleph Capital Partners Llp en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Notification de Barry Stuart Volpert en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2022 | 2 páginas | PSC01 | ||
Notification de Hugues Bernard Charles Lepic en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2022 | 2 páginas | PSC01 | ||
¿Quiénes son los directivos de DARAG INSURANCE UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOTH, Thomas Alexander | Director | Eastcheap 4th Floor EC3M 1DT London 25 England | United Kingdom | British | 255348500001 | |||||||||
| HEWETT, Mark James | Director | Eastcheap 4th Floor EC3M 1DT London 25 England | United Kingdom | British | 256855180001 | |||||||||
| RYAN, Adrian Peter | Director | Eastcheap 4th Floor EC3M 1DT London 25 England | Ireland | Irish | 296186450001 | |||||||||
| WILKES, Theo James Rickus | Director | Eastcheap 4th Floor EC3M 1DT London 25 England | United Kingdom | British | 329251230001 | |||||||||
| BHUHI, Susan Elizabeth | Secretario | 16 Charlwood Place RH2 9BA Reigate Surrey | British | 109326060001 | ||||||||||
| BOX, Paul Ernest | Secretario | Bishops Cleeve 1219 GL50 9WS Cheltenham The Grange United Kingdom | 202157100001 | |||||||||||
| D'ARPINO, Vincent Anthony | Secretario | 30 South Eaton Place SW1W 9JJ London | British | 60808640001 | ||||||||||
| LARWOOD, David Ronald | Secretario | 3 Tippersfield SS7 1JD South Benfleet Essex | British | 41148150001 | ||||||||||
| ROGERS, Shirley Lorna | Secretario | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 England | British | 51778930003 | ||||||||||
| ACUMEN GROUP MANAGEMENT LTD | Secretario corporativo | 37-39 Southgate Street SO23 9EH Winchester Southgate Chambers England |
| 287149790001 | ||||||||||
| CAPITA COMMERCIAL INSURANCE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | c/o Sue Colwill Bishops Cleeve 1219 GL50 9WS Cheltenham The Grange England |
| 123963920002 | ||||||||||
| BORNHUETTER, Ronald Lawrence | Director | 29 Old Stone Bridge Road Cos Cob Connecticutt 06807 Usa | American | 34840690001 | ||||||||||
| CARLSEN, Steven Walter | Director | One Shadowbrook Parkway Chappaqua New York 10514 Usa | Usa | Usa | 61709770001 | |||||||||
| CHEAL, Simon James | Director | Eastcheap 4th Floor EC3M 1DT London 25 England | United Kingdom | British | 186138620002 | |||||||||
| DAVIES, Stuart Robert | Director | Eastcheap 4th Floor EC3M 1DT London 25 England | England | British | 102224810002 | |||||||||
| GATELY, Dinah Janine | Director | Bishops Cleeve 1219 GL50 9WS Cheltenham The Grange United Kingdom | England | British | 95611330001 | |||||||||
| GOLDBERG, Alan Edward | Director | 695 West 246th Street Riverdale New York Ny 10471 Usa | American | 76539630001 | ||||||||||
| HASSE, Paul Thomas | Director | 3 Windcrest Drive Paget Pg05 Bermuda | Us Citizen | 61709980001 | ||||||||||
| HINES, Anthony Gordon | Director | Bishops Cleeve 1219 GL50 9WS Cheltenham The Grange United Kingdom | England | British | 34525570001 | |||||||||
| INSLEY, James Christopher Paul | Director | Eastcheap 4th Floor EC3M 1DT London 25 England | United Kingdom | British | 206149830001 | |||||||||
| INSLEY, James Christopher Paul | Director | Eastcheap 4th Floor EC3M 1DT London 25 England | United Kingdom | British | 206149830001 | |||||||||
| KATZENBERG, Roy | Director | Bishops Cleeve 1219 GL50 9WS Cheltenham The Grange United Kingdom | England | British | 121902840002 | |||||||||
| KIRWAN, Francis Xavier | Director | Gateside House Hill Road EH31 2BE Gullane East Lothian | British | 61709530001 | ||||||||||
| KLINE, Charles Lysle | Director | Knapton House 40 Knapton Hill Road Smiths Hso1 Bermuda | Us | 61710130001 | ||||||||||
| LARWOOD, David Ronald | Director | 24 Hillside Road Eastwood SS9 5DH Leigh On Sea Hillside Lodge Essex | British | 41148150005 | ||||||||||
| MCCRACKEN, Robert | Director | The Red House Burnt Oak Lane Waldron TN21 0NY Heathfield East Sussex | British | 61091760002 | ||||||||||
| MCKENZIE, Alexander James | Director | 33 Holywell Close West Canford Heath BH17 9BG Poole Dorset | England | British | 2653020001 | |||||||||
| NASH, Graham Paul | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 England | United Kingdom | British | 16514810001 | |||||||||
| ROCHAT, Christian Pierre | Director | 82 Palace Gardens Terrace W8 4RS London | England | Swiss | 70017700001 | |||||||||
| ROGERS, Nigel Harold John | Director | 3rd Floor 117 Fenchurch Street EC3M 5DY London | England | British By Birth | 76403660001 | |||||||||
| ROGERS, Shirley Lorna Lucy | Director | Bishops Cleeve 1219 GL50 9WS Cheltenham The Grange United Kingdom | England | British | 167805870001 | |||||||||
| ROTH, Alexander Thomas | Director | Eastcheap 4th Floor EC3M 1DT London 25 England | Germany | German | 292305870002 | |||||||||
| RUTTER, Keith John | Director | 71 Shearwater Court Star Place St Katherines Dock E1W 1AD London | British | 62466630005 | ||||||||||
| SCHWED, Gustavo Rodolfo | Director | 13 Blenheim Road NW8 0LU London | American | 75831210001 | ||||||||||
| SIEGAL, Jeffrey Marc | Director | 340 E 80th Street Apt 8e New York Usa | Us Citizen | 97094230001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DARAG INSURANCE UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleph Capital Partners Limited | 03 may 2023 | St. George Street W1S 1FE London 14 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Aleph Capital Partners Llp | 28 mar 2022 | St. George Street W1S 1FE London 14 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Barry Stuart Volpert | 28 mar 2022 | Madison Avenue 42nd Floor NY 10022 New York 590 United States | No | ||||||||||
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Hugues Bernard Charles Lepic | 28 mar 2022 | St. George Street W1S 1FE London 14 United Kingdom | No | ||||||||||
Nacionalidad: French País de residencia: United Kingdom | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Polo Holdings Feeder Lp | 22 sept 2020 | East Wing Trafalgar Court Les Banques 656 GY1 3PP St Peters Port PO BOX 656 Guernsey | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Keyhaven Growth Partners Ii L.P | 05 feb 2020 | Lothian Road EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Keyhaven Growth Partners L.P. | 05 feb 2020 | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Polo Holdings Feeder L.P. | 05 feb 2020 | Les Banques St Peter Port 656 GY1 3PP Guernsey East Wing Trafalgar Court Guernsey | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| The Underwriter Group Limited | 30 mar 2017 | Bishops Cleeve 1219 GL50 9WS Cheltenham The Grange England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Ship (2006) Limited | 06 abr 2016 | C/O Norose Company Secretarial Services Ltd 3 More Riverside London Se1 2aq 3 Moor Riverside United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0