CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03807755 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Unit H, Littleton House Littleton Road TW15 1UU Ashford Middlesex United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LONGVILLE GROUP LIMITED | 04 oct 1999 | 04 oct 1999 |
| INGLEBY (1215) LIMITED | 15 jul 1999 | 15 jul 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 13 jul 2024 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr John Anthony Robinson el 01 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Neil Andrew Vincent Gregor Macgregor el 01 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Porsham Close Belliver Industrial Estate Plymouth Devon PL6 7DB England a Unit H, Littleton House Littleton Road Ashford Middlesex TW15 1UU el 08 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Neil Andrew Vincent Gregor Macgregor el 24 oct 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Estado de capital el 15 mar 2023
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 8 páginas | MA | ||||||||||||||||||
Subdivisión de acciones el 23 feb 2023 | 6 páginas | SH02 | ||||||||||||||||||
Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones | 2 páginas | SH10 | ||||||||||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 21 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Boniface como secretario el 09 dic 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr John Anthony Robinson como director el 09 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Andrew Vincent Gregor Macgregor como director el 09 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREGOR MACGREGOR, Neil Andrew Vincent | Director | Littleton Road TW15 1UU Ashford Unit H, Littleton House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 286329300004 | |||||
| ROBINSON, John Anthony | Director | Littleton Road TW15 1UU Ashford Unit H, Littleton House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 205997980001 | |||||
| ATTRILL, Christopher Richard | Secretario | 9 The Chines Delamere Park CW8 2XA Cuddington Cheshire | British | 93024670001 | ||||||
| BONIFACE, Simon | Secretario | Guildford Road Fetcham KT22 9UT Leatherhead United Technologies House England | 250226760001 | |||||||
| BROADBENT, Garry Keith | Secretario | 24 Heron Way FY3 8FB Blackpool Lancashire | British | 45362230002 | ||||||
| D'CRUZ, Agnes Mary | Secretario | Guildford Road Fetcham KT22 9UT Leatherhead United Technologies House Surrey England | Malaysian | 110058870001 | ||||||
| FOSTER, David Eric | Secretario | 3 Leadhall Drive HG2 9NL Harrogate North Yorkshire | British | 54143460001 | ||||||
| HARBRIDGE, Simon Richard | Secretario | Marlbrook Lane Sale Green WR9 7LW Droitwich Charlbury House Worcestershire | British | 105161460002 | ||||||
| LEDGER, Ray | Secretario | 4 Brunswick House 5-6 Mansfield Court HG1 2QT Harrogate North Yorkshire | British | 98530780001 | ||||||
| SLOSS, Robert | Secretario | Unit B Colima Avenue Sunderland Enterprise Park West SR5 3XE Sunderland | 201315100001 | |||||||
| WILCOCK, Laura | Secretario | Unit B Colima Avenue Sunderland Enterprise Park West SR5 3XE Sunderland | 201314890001 | |||||||
| INGLEBY NOMINEES LIMITED | Secretario designado corporativo | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
| ATTRILL, Christopher Richard | Director | 9 The Chines Delamere Park CW8 2XA Cuddington Cheshire | England | British | 93024670001 | |||||
| BLABY, Steven James | Director | Church Road GL15 5EL Lydney Watkins Hire Ltd England | England | British | 250616320001 | |||||
| BROADBENT, Garry Keith | Director | Mullberry House Meadowview, Great Plumpton PR4 3NF Preston | United Kingdom | British | 45362230003 | |||||
| CLUBB, Ian Mcmaster | Director | Pond House EN5 4PS Hadley Green Hertfordshire | British | 3485960001 | ||||||
| DAVY, Michael Robert | Director | Gresham Gardens Golders Green NW11 8PD London 34 | England | British | 132050710001 | |||||
| DENNING, Roland John | Director | Swallowfield Grange The Street RG7 1RE Swallowfield Berkshire | England | British | 95991510001 | |||||
| FOSTER, David Eric | Director | 3 Leadhall Drive HG2 9NL Harrogate North Yorkshire | British | 54143460001 | ||||||
| GOOCH, Alexandra Elizabeth | Director | Belliver Industrial Estate PL6 7DB Plymouth Porsham Close Devon England | England | British | 286825110001 | |||||
| GORNALL, David | Director | Gometra Little Stainton Bishopton TS21 1HN Stockton On Tees | United Kingdom | British | 76417460004 | |||||
| GREEN, Derek | Director | Rosedale House Brandreth Delph, Parbold WN8 7AQ Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 166954440001 | |||||
| HARBRIDGE, Simon Richard | Director | Marlbrook Lane Sale Green WR9 7LW Droitwich Charlbury House Worcestershire | England | British | 105161460002 | |||||
| HOOK, Eric Ward | Director | Woodside House Longville In The Dale TF13 6DR Much Wenlock Shropshire | England | British | 39185740002 | |||||
| HUGHES, Jonathan Raoul | Director | 4 Sudbrooke Road SW12 8TG London | British | 61123800001 | ||||||
| HUNGWE, Archibald Ziwanemoyo | Director | Guildford Road KT22 9UT Leatherhead United Technologies House Surrey England | England | British | 240353160001 | |||||
| JONES, Richard Hilton | Director | Guildford Road Fetcham KT22 9UT Leatherhead United Technologies House Surrey England | England | British | 101090610001 | |||||
| KELLEHER, Brian Edward | Director | 7 Spring Meadow Lane 06035 Granby Connecticut Usa | American | 117635100001 | ||||||
| LEDGER, Ray | Director | 4 Brunswick House 5-6 West Park HG1 2QT Harrogate North Yorkshire | British | 93270980001 | ||||||
| MAKHARINE, Muriel | Director | 121 Northington Drive Avon Ct 06601 United States | Usa | French | 132639020001 | |||||
| MCDONALD, Steven Thomas | Director | Roborough PL6 7DB Plymouth Porsham Close England | England | British | 133653510001 | |||||
| MCMULLEN, Simon Ross Harden | Director | Stockley Close UB7 9BL West Drayton 365 England | England | British | 132089160001 | |||||
| MCMULLEN, Simon Ross Harden | Director | Priory Road Chalfont St Peter SL9 8SB Gerrards Cross 7 Buckinghamshire | England | British | 132089160001 | |||||
| PADDOCK, Andrew Justin | Director | Guildford Road Fetcham KT22 9UT Leatherhead United Technologies House England | England | British | 246915550001 | |||||
| PAYNE, Alan Douglas | Director | 112 Northfield Road Kings Norton B30 1JG Birmingham West Midlands | British | 74345940001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matlock Holdings Ltd | 07 may 2019 | Littleton Road TW15 1TZ Ashford 1st Floor Ash House Middlesex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| United Technologies Holdings Limited | 15 jul 2016 | Littleton Road TW15 1TZ Ashford 1st Floor Ash House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 15 jul 2016 | 15 jul 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0