COUNTRYSIDE PROPERTIES (BICESTER) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | COUNTRYSIDE PROPERTIES (BICESTER) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04165427 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COUNTRYSIDE PROPERTIES (BICESTER) LIMITED?
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra COUNTRYSIDE PROPERTIES (BICESTER) LIMITED?
Dirección de la sede social | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COUNTRYSIDE PROPERTIES (BICESTER) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
FOX LANE (CHERTSEY) LIMITED | 02 may 2001 | 02 may 2001 |
CHOQS 389 LIMITED | 22 feb 2001 | 22 feb 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COUNTRYSIDE PROPERTIES (BICESTER) LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COUNTRYSIDE PROPERTIES (BICESTER) LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 nov 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 24 nov 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 nov 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COUNTRYSIDE PROPERTIES (BICESTER) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2023 | 22 páginas | AA | ||
Cessation de Countryside Properties (Housebuilding) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 dic 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Countryside Properties (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 dic 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||
Nombramiento de Mr William James House como director el 22 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2022 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Vistry Secretary Limited como secretario el 12 sept 2023 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Philip Andrew Chapman como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Mccormack como secretario el 31 dic 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2021 | 21 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Peter Mccormack como secretario el 01 ene 2022 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Tracy Marina Warren como secretario el 31 dic 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Notification de Countryside Properties (Housebuilding) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 abr 2021 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Countryside Properties (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 abr 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Countryside Properties (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 abr 2021 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Countryside Properties (Joint Ventures) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 abr 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||
Nombramiento de Mr Philip Andrew Chapman como director el 26 abr 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Phillip Victor Lyons como director el 26 abr 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020 | 23 páginas | AA | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019 | 22 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Martin Geoffrey Leach como director el 27 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de COUNTRYSIDE PROPERTIES (BICESTER) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTRY SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent United Kingdom |
| 284895390001 | ||||||||||
BORWICK, Geoffrey Robert James, Lord | Director | 33 Phillimore Gardens W8 7QG London | England | British | Director | 1709090001 | ||||||||
BORWICK, Thomas James Robert | Director | Great College Street SW1P 3RX London 15 England | United Kingdom | British | Director | 135577510002 | ||||||||
HOBDEN, Christopher Martin | Director | 10 Kent Terrace Regents Park NW1 4RP London | United Kingdom | British | Director | 73891520003 | ||||||||
HOUSE, William James | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | Director | 206266010001 | ||||||||
LEACH, Martin Geoffrey | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | Land Director | 93744720001 | ||||||||
STEPHENS, Rupert James | Director | Weymouth Street W1G 6NU London 54 Greater London England | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 154527100001 | ||||||||
HOYLES, Robin Patrick | Secretario | 12 Springpark Drive BR3 6QD Beckenham Kent | British | Solicitor Company Director | 34860250001 | |||||||||
MCCORMACK, Peter | Secretario | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House United Kingdom | 291199400001 | |||||||||||
SHILLINGLAW, Gary Preston | Secretario | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||||||
WARREN, Tracy Marina | Secretario | Hollow Road Felsted CM6 3JF Dunmow The Molehill Essex United Kingdom | British | 132463120001 | ||||||||||
C H REGISTRARS LIMITED | Secretario corporativo | 35 Old Queen Street SW1H 9JD London | 39694450001 | |||||||||||
CARRINGTON, Andrew Mark | Director | Avondale Avenue Hinchley Wood KT10 0DA Esher 68 Surrey England | England | British | Commercial Director | 117610380001 | ||||||||
CHAPMAN, Philip Andrew | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | Director | 183918150002 | ||||||||
CHATHAM, Mark Philip | Director | Ragstones 16 Durlings Orchard Ightham TN15 9HW Sevenoaks Kent | England | British | Chartered Surveyor | 27018500002 | ||||||||
CHERRY, Graham Stewart | Director | Fridays Fox Road Mashbury CM1 4TJ Chelmsford Essex | United Kingdom | British | Director | 7228590002 | ||||||||
CHERRY, Richard Stephen | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | Company Director | 68733260003 | ||||||||
CRAYMER, Jacqueline Anne | Director | The Green White Notley CM8 1RG Witham Hatchcroft House Essex England | England | British | Company Director | 97827510001 | ||||||||
DE BLABY, Richard Armand | Director | The Square House Smithbrook Lodsworth GU28 9DG Petworth West Sussex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 109841060001 | ||||||||
GALLAGHER, Mark | Director | Cromwell Lane CM9 4LB Maldon 21 Essex England | England | British | Chartered Surveyor | 3110930001 | ||||||||
HOYLES, Robin Patrick | Director | 12 Springpark Drive BR3 6QD Beckenham Kent | United Kingdom | British | Solicitor | 34860250001 | ||||||||
LYONS, Phillip Victor | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | Chief Executive - Housebuilding | 231980680001 | ||||||||
SETHI, Nishi | Director | 3 Upsdell Avenue N13 6JP London | England | British | Legal Secretary | 62629070001 | ||||||||
WEBLEY, Andrew Charles | Director | 33 Ashburnham Grove SE10 8UL London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 20964200001 | ||||||||
WRIGHT, Martin James | Director | Well Cottage Well House Lane RH15 0BN Burgess Hill West Sussex | United Kingdom | British | Solicitor | 4403900006 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COUNTRYSIDE PROPERTIES (BICESTER) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Countryside Properties (Uk) Limited | 08 dic 2023 | The Drive CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Countryside Properties (Housebuilding) Limited | 21 abr 2021 | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Countryside Properties (Uk) Limited | 21 abr 2021 | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Countryside Properties (Joint Ventures) Limited | 06 abr 2016 | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Bicester Lane Limited | 06 abr 2016 | The Green White Notley CM8 1RG Witham Hatchcroft House Essex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0