MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 08033025 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?
- Recolección de residuos no peligrosos (38110) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
- Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos (38210) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
- Recuperación de materiales clasificados (38320) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
¿Dónde se encuentra MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?
| Dirección de la sede social | Suez House Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Berkshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SITA SEMBCORP UK LIMITED | 30 abr 2012 | 30 abr 2012 |
| SHUKCO 312A LIMITED | 17 abr 2012 | 17 abr 2012 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 17 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 01 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 17 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr. Richard Geoffrey Little como director el 30 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Daniel Geoffrey North como director el 30 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 36 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Philip Bruce Sheffer como director el 25 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr. David Anthony Morris como director el 07 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr. Iqbal Singh Sidhu como director el 20 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Thomas Patrick como director el 20 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr. Philip Bruce Sheffer como director el 20 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew John Cottrell como director el 31 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr. Daniel North como director el 15 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr. Neil Rae como director el 15 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Kazuma Fukao como director el 15 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Rahul Dipinkumar Kadiwar como director el 15 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 36 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr. Andrew John Cottrell como director el 01 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 36 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Belinda Faith Knox como director el 01 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Rahul Dipinkumar Kadiwar como director el 01 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Keith Thompson como director el 31 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Masashi Kanai como director el 01 abr 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Kazuma Fukao como director el 01 abr 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 36 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK LTD | Secretario corporativo | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England |
| 114869260003 | ||||||||||
| LITTLE, Richard Geoffrey, Mr. | Director | 1 Gresham Street EC2V 7BX London Semperian, 4th Floor England | England | British | 151062990002 | |||||||||
| MORRIS, David Anthony, Mr. | Director | Wilton International Manufacturing Site TS90 8WS Redcar Cleveland Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | British | 335522840001 | |||||||||
| PADFIELD, Amanda | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 159090300001 | |||||||||
| RAE, Neil, Mr. | Director | 1 Gresham Street EC2V 7BX London Semperian, 4th Floor England | United Kingdom | British | 119437600003 | |||||||||
| SIDHU, Iqbal Singh, Mr. | Director | Wilton International Manufacturing Site TS90 8WS Redcar, Cleveland Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | United Kingdom | British | 332910240001 | |||||||||
| THOMPSON, Mark Hedley | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 162837220002 | |||||||||
| THORN, Christopher Derrick, Mr. | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 266799220001 | |||||||||
| KNIGHT, Joan | Secretario | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Sita House Berkshire England | 168388440001 | |||||||||||
| AHMAD, Nauman | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | Pakistani | 246516040001 | |||||||||
| ANNAN, Douglas Stuart, Dr | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 165609970001 | |||||||||
| BONE, Dugald John, Dr | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Sita House Berkshire England | England | British | 84834380001 | |||||||||
| CHAPRON, Christophe Andre Bernard | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Sita House Berkshire England | England | French | 122645500003 | |||||||||
| CHONG, Kwong Fatt | Director | Wilton Internation TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters Cleveland England | Singapore | Singaporean | 183833580001 | |||||||||
| COTTRELL, Andrew John | Director | Wilton International TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | United Kingdom | British | 334057500001 | |||||||||
| FUKAO, Kazuma | Director | 20 Primrose Street EC2A 2EW London The Broadgate Tower England | England | Japanese | 308897090001 | |||||||||
| GAVIN, Paul | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Sita House Berkshire England | England | British | 159027960001 | |||||||||
| HANDS, Stephen Christopher | Director | Wilton Internation TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters Cleveland England | England | British | 205116300001 | |||||||||
| HIBINO, Tsuneharu | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | Japanese | 168730210001 | |||||||||
| HIGASHIYAMA, Eiichiro | Director | The Broadgate Tower, 20 Primrose Street EC2A 2EW London I-Environment Investments Ltd England | England | Japanese | 195916850001 | |||||||||
| KADIWAR, Rahul Dipinkumar | Director | 20 Primrose Street EC2A 2EW London I-Environment Investments Ltd, The Broadgate Tower England | England | British | 313395690001 | |||||||||
| KANAI, Masashi | Director | 20 Primrose Street EC2A 2EW London The Broadgate Tower England | England | Japanese | 282813470002 | |||||||||
| KNOX, Belinda Faith | Director | 20 Primrose Street EC2A 2EW London The Broadgate Tower England | England | British | 190578640001 | |||||||||
| MCCLAY, Catherine Isabel, Dr | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 245734420001 | |||||||||
| MCKENNA-MAYES, Graham Arthur | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 91435430011 | |||||||||
| NG, Meng Poh | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | Singapore | Singaporean | 150975730001 | |||||||||
| NORTH, Daniel Geoffrey | Director | 1 Gresham Street EC2V 7BX London Semperian, 4th Floor England | England | British | 259587080001 | |||||||||
| PALMER-JONES, David Courtenay | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Sita House Berkshire England | United Kingdom | British | 125070620001 | |||||||||
| PATRICK, Michael Thomas | Director | Wilton International Manufacturing Site TS90 8WS Redcar Sembcorp Uk Headquarters Cleveland United Kingdom | England | British | 293354340001 | |||||||||
| SCRIMSHAW, Matthew Giles | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | England | British | 265146200001 | |||||||||
| SEXTON, Ian Anthony | Director | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House Berkshire England | France | British | 182259120001 | |||||||||
| SHEFFER, Philip Bruce, Mr. | Director | Wilton International Manufacturing Site TS90 8WS Redcar, Cleveland Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | British | 332909490001 | |||||||||
| SUZUKI, Yuji | Director | Primrose Street EC2A 2EW London The Broadgate Tower England | England | Japanese | 236854110002 | |||||||||
| THOMPSON, David Keith | Director | Wilton International Manufacturing Site TS90 8WS Redcar Sembcorp Uk Headquarters Cleveland United Kingdom | England | British | 265146580001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merseyside Energy Recovery Holdings Ltd | 06 abr 2016 | Grenfell Road SL6 1ES Maidenhead Suez House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0