CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED

CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC004676
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    13 páginas4.26(Scot)

    Cese del nombramiento de Justin Bruce Robinson como director el 14 sept 2018

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del secretario Haysmacintyre Company Secretaries Limited el 18 dic 2017

    1 páginasCH04

    Cambio de datos del director Mr Patrick Thomas Mabry el 18 dic 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 18 dic 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Simon Michael Teasdale el 18 dic 2017

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Holiday Inn 107 Queensferry Road Edinburgh EH4 3HL a Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG el 03 nov 2017

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 20 oct 2017

    LRESSP

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga SC0046760005

    5 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga SC0046760004

    5 páginasMR05

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    19 páginasAA

    Estado de capital el 10 jul 2017

    • Capital: GBP 0.10
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 03 feb 2017

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 02 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    15 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 20 feb 2016

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 02 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 ene 2016

    Estado de capital el 14 ene 2016

    • Capital: GBP 5,793,030.4
    SH01

    Cese del nombramiento de Paul Loynes como director el 17 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ivaylo Kolev como director el 17 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Loynes como secretario el 17 dic 2015

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Skardon Francis Baker como director el 17 dic 2015

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4682161
    89121630002
    MABRY, Patrick Thomas
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Director
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    LuxembourgGerman204005420001
    TEASDALE, Simon Michael
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Director
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    United KingdomBritish204008350001
    BOLTON, Susan
    10 Haygreen Close
    KT2 7TS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    10 Haygreen Close
    KT2 7TS Kingston Upon Thames
    Surrey
    British59426570001
    COMBEER, Jean Brenda
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    Secretario
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    British50345500001
    COMBEER, Jean Brenda
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    Secretario
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    British50345500001
    CRANE, Julia Alison
    27 Hatton Court
    Lubbock Road
    BR7 5JQ Chislehurst
    Kent
    Secretario
    27 Hatton Court
    Lubbock Road
    BR7 5JQ Chislehurst
    Kent
    British46318020001
    ENGMANN, Catherine
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    Secretario
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    British92722710002
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Secretario
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    203612770001
    TOON, Samantha Anne
    10 St.Anthonys Court
    Nightingale Lane
    SW12 8NS London
    Secretario
    10 St.Anthonys Court
    Nightingale Lane
    SW12 8NS London
    British32930670001
    WHITNEY, Paul Sumpter
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    Secretario
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    British418890001
    WILLIAMS, Alison
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    Secretario
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    British78744290002
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4682161
    89121630002
    PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
    Ten Bishops Square
    Eighth Floor
    E1 6EG London
    10
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Ten Bishops Square
    Eighth Floor
    E1 6EG London
    10
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro04131463
    125623230001
    BAKER, Skardon Francis
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Director
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United KingdomAmerican196342720001
    CASTON, Robert Warwick
    Square De Heeus 20
    FOREIGN 1400 Brussels
    Belgium
    Director
    Square De Heeus 20
    FOREIGN 1400 Brussels
    Belgium
    British1311840002
    EKAS, Petra Cecilia Maria
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Director
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    United KingdomDutch169731050002
    FISH, Andrew John
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Director
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish77133450001
    GRAHAM, Ian Christopher
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    Director
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    British31551670001
    JACKMAN, Robert Loehr
    4 Durning Place
    SL5 7EZ Ascot
    Berkshire
    Director
    4 Durning Place
    SL5 7EZ Ascot
    Berkshire
    American35835670003
    KOLEV, Ivaylo
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Director
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    UkBulgarian193389430001
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Director
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish241370450001
    MCCARTHY, John Patrick
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    Director
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    United States112396050001
    MCEWAN, Allan Scott
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Director
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish75569660002
    NEWMAN, Mark
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    Director
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    United KingdomCanadian62529820001
    PRINCE, Ryan David
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomCanadian85682450077
    REES, Sally Irene
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    Director
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    EnglandBritish49954790002
    RITSON, Leslie David
    Old Middle Cator House
    Cator Widecombe In The Moor
    TQ13 7UA Newton Abbot
    Devonshire
    Director
    Old Middle Cator House
    Cator Widecombe In The Moor
    TQ13 7UA Newton Abbot
    Devonshire
    British26098610002
    ROBINSON, Justin Bruce
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Director
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    United KingdomBritish225299130001
    SPRINGETT, Catherine Mary
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    Director
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    United KingdomBritish147336720001
    STOCKS, Nigel Peter
    Birdwoods
    School Lane Shackleford
    GU8 6AZ Godalming
    Surrey
    Director
    Birdwoods
    School Lane Shackleford
    GU8 6AZ Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish147336730001
    VAN OOSTEROM, Sophie
    Orlando Road
    SW4 0LD London
    19
    United Kingdom
    Director
    Orlando Road
    SW4 0LD London
    19
    United Kingdom
    United KingdomDutch139801070001
    WHITNEY, Paul Sumpter
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    Director
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    British418890001
    WINTER, Richard Thomas
    33 St Johns Avenue
    Putney
    SW15 6AL London
    Director
    33 St Johns Avenue
    Putney
    SW15 6AL London
    United KingdomBritish6308500001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00719804
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 dic 2015
    Entregado el 02 dic 2015
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Societe Generale, London Branch
    Transacciones
    • 02 dic 2015Registro de una carga (MR01)
    • 26 oct 2017Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    A registered charge
    Creado el 01 dic 2015
    Entregado el 02 dic 2015
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Societe Generale, London Branch.
    Transacciones
    • 02 dic 2015Registro de una carga (MR01)
    • 26 oct 2017Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    A registered charge
    Creado el 22 may 2013
    Entregado el 03 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The security agreement among others the ocmpany and the common security agent creates a fixed charge over present and future land and intellectual property rights owned by the company. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 03 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 03 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 22 may 2013
    Entregado el 03 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 03 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 03 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Memorandum of deposit
    Creado el 13 feb 1966
    Entregado el 22 feb 1966
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Leasehold premises at kenilworth hotel, great russell street, waverley hotel, southampton row and ivanhoe hotel, bloomsbury street, london.
    Personas con derecho
    • National Commercial Bank of Scotland LTD.
    Transacciones
    • 22 feb 1966Registro de un cargo (MG01s)
    • 09 mar 1967Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04s)
    • 30 may 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 oct 2017Inicio de la liquidación
    08 jun 2019Fecha prevista de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0