CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC004676 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria | 13 páginas | 4.26(Scot) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Justin Bruce Robinson como director el 14 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Haysmacintyre Company Secretaries Limited el 18 dic 2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Patrick Thomas Mabry el 18 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 18 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Simon Michael Teasdale el 18 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Holiday Inn 107 Queensferry Road Edinburgh EH4 3HL a Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG el 03 nov 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga SC0046760005 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga SC0046760004 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Estado de capital el 10 jul 2017
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 03 feb 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 20 feb 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Loynes como director el 17 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ivaylo Kolev como director el 17 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Loynes como secretario el 17 dic 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Skardon Francis Baker como director el 17 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Director | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh Saltire Court | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Director | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh Saltire Court | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| BOLTON, Susan | Secretario | 10 Haygreen Close KT2 7TS Kingston Upon Thames Surrey | British | 59426570001 | ||||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Secretario | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Secretario | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| CRANE, Julia Alison | Secretario | 27 Hatton Court Lubbock Road BR7 5JQ Chislehurst Kent | British | 46318020001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Secretario | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Secretario | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203612770001 | |||||||||||
| TOON, Samantha Anne | Secretario | 10 St.Anthonys Court Nightingale Lane SW12 8NS London | British | 32930670001 | ||||||||||
| WHITNEY, Paul Sumpter | Secretario | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Secretario | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Ten Bishops Square Eighth Floor E1 6EG London 10 United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Director | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| CASTON, Robert Warwick | Director | Square De Heeus 20 FOREIGN 1400 Brussels Belgium | British | 1311840002 | ||||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Director | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Director | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| GRAHAM, Ian Christopher | Director | Avenue Venus 2 1410 Waterloo Belgium | British | 31551670001 | ||||||||||
| JACKMAN, Robert Loehr | Director | 4 Durning Place SL5 7EZ Ascot Berkshire | American | 35835670003 | ||||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Director | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Director | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Director | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Director | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| NEWMAN, Mark | Director | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PRINCE, Ryan David | Director | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 | |||||||||
| REES, Sally Irene | Director | 3 Sandown Gate KT10 9LB Esher Surrey | England | British | 49954790002 | |||||||||
| RITSON, Leslie David | Director | Old Middle Cator House Cator Widecombe In The Moor TQ13 7UA Newton Abbot Devonshire | British | 26098610002 | ||||||||||
| ROBINSON, Justin Bruce | Director | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh Saltire Court | United Kingdom | British | 225299130001 | |||||||||
| SPRINGETT, Catherine Mary | Director | The Coach House 32 Kerrison Road Ealing W5 5NW London | United Kingdom | British | 147336720001 | |||||||||
| STOCKS, Nigel Peter | Director | Birdwoods School Lane Shackleford GU8 6AZ Godalming Surrey | United Kingdom | British | 147336730001 | |||||||||
| VAN OOSTEROM, Sophie | Director | Orlando Road SW4 0LD London 19 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 139801070001 | |||||||||
| WHITNEY, Paul Sumpter | Director | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
| WINTER, Richard Thomas | Director | 33 St Johns Avenue Putney SW15 6AL London | United Kingdom | British | 6308500001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribbon Hotels Group (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 01 dic 2015 Entregado el 02 dic 2015 | Pendiente | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 01 dic 2015 Entregado el 02 dic 2015 | Pendiente | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 22 may 2013 Entregado el 03 jun 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción The security agreement among others the ocmpany and the common security agent creates a fixed charge over present and future land and intellectual property rights owned by the company. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 22 may 2013 Entregado el 03 jun 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Memorandum of deposit | Creado el 13 feb 1966 Entregado el 22 feb 1966 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Leasehold premises at kenilworth hotel, great russell street, waverley hotel, southampton row and ivanhoe hotel, bloomsbury street, london. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0