CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC028224 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED?
- Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción
- Alquiler y arrendamiento de otras máquinas, equipo y bienes tangibles n.c.p. (77390) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 8 Maxwell Square Brucefield Industrial Park EH54 9BL Livingston United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LONGVILLE LIMITED | 28 abr 2000 | 28 abr 2000 |
| SLD PUMPS LIMITED | 29 mar 1951 | 29 mar 1951 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 22 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 05 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancelación total de la carga 10 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 11 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 12 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 39 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mrs Moana Blaudet Ep. Barruel como director el 08 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mrs Moana Blaudet Ep. Barruel como secretario el 08 dic 2025 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Justin Paddock como director el 19 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Romuald Gilbert Jack Thierry como secretario el 24 nov 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Steven James Blaby como director el 11 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Carrier Uk Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 39 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Boniface como secretario el 28 ago 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Romuald Gilbert Jack Thierry como secretario el 28 ago 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 40 páginas | AA | ||||||||||||||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 22 may 2023 | 3 páginas | RP04CS01 | ||||||||||||||
Notification de Carrier Uk Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 feb 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Carrier Rental Systems Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 feb 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 may 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 8 páginas | MA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones | 2 páginas | SH10 | ||||||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ailsa Road Irvine Industrial Estate Irvine Ayrshire KA12 8LL a 8 Maxwell Square Brucefield Industrial Park Livingston EH54 9BL el 20 feb 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAUDET EP. BARRUEL, Moana | Secretario | Maxwell Square Brucefield Industrial Park EH54 9BL Livingston 8 United Kingdom | 343327090001 | |||||||
| BLAUDET EP. BARRUEL, Moana | Director | Maxwell Square Brucefield Industrial Park EH54 9BL Livingston 8 United Kingdom | France | French | 343326620001 | |||||
| GOOCH, Alexandra Elizabeth | Director | Maxwell Square Brucefield Industrial Park EH54 9BL Livingston 8 United Kingdom | England | British | 286825110001 | |||||
| ATTRILL, Christopher Richard | Secretario | 9 The Chines Delamere Park CW8 2XA Cuddington Cheshire | British | 93024670001 | ||||||
| BONIFACE, Simon | Secretario | Guildford Road Fetcham KT22 9UT Leatherhead United Technologies House England | 250226550001 | |||||||
| D'CRUZ, Agnes Mary | Secretario | Guildford Road Fetcham KT22 9UT Leatherhead United Technologies House Surrey England | Malaysian | 110058870001 | ||||||
| DWYER, Maurice John | Secretario | 29 Beechwood Avenue Earlsdon CV5 6DF Coventry Warwickshire | British | 77054540001 | ||||||
| FOSTER, David Eric | Secretario | 3 Leadhall Drive HG2 9NL Harrogate North Yorkshire | British | 54143460001 | ||||||
| HARBRIDGE, Simon Richard | Secretario | Marlbrook Lane Sale Green WR9 7LW Droitwich Charlbury House Worcestershire | British | 105161460002 | ||||||
| SLOSS, Robert | Secretario | Ailsa Road Irvine Industrial Estate KA12 8LL Irvine Ayrshire | 201314820001 | |||||||
| THIERRY, Romuald Gilbert Jack | Secretario | Maxwell Square Brucefield Industrial Park EH54 9BL Livingston 8 United Kingdom | 326690180001 | |||||||
| WAKEFIELD, Josephine | Secretario | 8 Grasslees Rickleton NE38 9JA Washington Tyne & Wear | British | 594640001 | ||||||
| WILCOCK, Laura | Secretario | Ailsa Road Irvine Industrial Estate KA12 8LL Irvine Ayrshire | 201314710001 | |||||||
| ADAMS, Simon | Director | 9 Hope Place Levenhall EH21 7QD Musselburgh Midlothian | British | 109859010001 | ||||||
| ANTIGNAC, Laurence | Director | Ailsa Road Irvine Industrial Estate KA12 8LL Irvine Ayrshire | France | French | 209137530001 | |||||
| ASHFORD, Leslie Ernest Thomas | Director | 27 Beckenham Road BR4 0QR West Wickham Kent | England | British | 398670001 | |||||
| ATTRILL, Christopher Richard | Director | 9 The Chines Delamere Park CW8 2XA Cuddington Cheshire | England | British | 93024670001 | |||||
| BENJAMIN, Trevor James Francis | Director | 24 High View Ponteland NE20 9ET Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 594670001 | ||||||
| BLABY, Steven James | Director | Church Road GL15 5EL Lydney Watkins Hire Ltd England | England | British | 250616320001 | |||||
| BOWERS, Gillian | Director | 2 Glebe Field Chase Wetherby LS22 6WE Leeds West Yorkshire | British | 105619270001 | ||||||
| BRENNAN, Anthony | Director | Littleton Road TW15 1TZ Ashford Chubb Middlesex England | England | British | 187183280001 | |||||
| BROADBENT, Garry Keith | Director | Mullberry House Meadowview, Great Plumpton PR4 3NF Preston | United Kingdom | British | 45362230003 | |||||
| BROWSE, Keith Dennis William | Director | Wigan Road PR25 5XW Leyland Carrier Rental Systems Uk Ltd Lancashire England | United Kingdom | British | 130806240001 | |||||
| CALDWELL, Christopher James | Director | 1 Hardy Close Westhoughton BL5 3BS Bolton Grt Manchester | England | British | 88834460001 | |||||
| CHAMBERLAIN, William Harry | Director | 5 Hazel Grove Bamber Bridge PR5 6PN Preston Lancashire | British | 1189340001 | ||||||
| CLARK, Trevor William | Director | 1 Staintondale Road The Chase DL5 7LG Newton Aycliffe Co Durham | British | 594970001 | ||||||
| DOBSON, Keith | Director | 8 Town Farm Close Bishopton TS21 1HX Stockton On Tees Cleveland | British | 594660001 | ||||||
| DOBSON, Keith | Director | 8 Town Farm Close Bishopton TS21 1HX Stockton On Tees Cleveland | British | 594660001 | ||||||
| FOSTER, David Eric | Director | 3 Leadhall Drive HG2 9NL Harrogate North Yorkshire | British | 54143460001 | ||||||
| GARDNER, Ian James | Director | 28 Colliers Break Emersons Green BS16 7EE Bristol Avon | England | British | 100278530001 | |||||
| GARRETT, Stephen George | Director | 4 Gowanburn Fatfield NE38 8SG Washington Tyne & Wear | British | 88834570001 | ||||||
| GRAHAM, Christopher Gordon | Director | 19 Langford Close IP14 1TX Stowmarket Suffolk | British | 88834440001 | ||||||
| HARBRIDGE, Simon Richard | Director | Marlbrook Lane Sale Green WR9 7LW Droitwich Charlbury House Worcestershire | England | British | 105161460002 | |||||
| HARPER, Peter Joseph | Director | Mayhall Lodge Oakway HP6 5PQ Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 133340001 | |||||
| HARVEY, Lindsay Eric | Director | 566 Chiswick High Road W4 5YF Chiswick Chiswick Park Building 5 London England | England | British | 130828160004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrier Uk Holdings Limited | 23 feb 2023 | Littleton Road TW15 1UU Ashford Unit H, Littleton House Middlesex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Carrier Rental Systems Limited | 27 may 2017 | Colima Avenue Sunderland Enterprise Park SR5 3XE Sunderland Unit B England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CARRIER RENTAL SYSTEMS (UK) LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 22 may 2017 | 27 may 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0