DAWN CHORUS (HOLDINGS)

DAWN CHORUS (HOLDINGS)

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDAWN CHORUS (HOLDINGS)
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa SC042391
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DAWN CHORUS (HOLDINGS)?

    • (7415) /

    ¿Dónde se encuentra DAWN CHORUS (HOLDINGS)?

    Dirección de la sede social
    Pacific Quay
    Glasgow
    G51 1PQ
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DAWN CHORUS (HOLDINGS)?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SMG TELEVISION LIMITED18 dic 200018 dic 2000
    SCOTTISH MEDIA GROUP PLC16 may 199716 may 1997
    SCOTTISH TELEVISION PUBLIC LIMITED COMPANY08 jul 196508 jul 1965

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DAWN CHORUS (HOLDINGS)?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DAWN CHORUS (HOLDINGS)?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 feb 2011

    Estado de capital el 01 feb 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    8 páginasAA

    Estado de capital el 29 abr 2010

    • Capital: GBP 2
    4 páginasSH19

    Misceláneos

    SH02
    5 páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Consolidation 01/04/2010
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    30 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Various appointments 01/04/2010
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01

    Cambio de datos del secretario Jane Elizabeth Anne Tames el 14 ene 2010

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director William George Watt el 02 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    7 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    7 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    8 páginasAA

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas287

    ¿Quiénes son los directivos de DAWN CHORUS (HOLDINGS)?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TAMES, Jane Elizabeth Anne
    G51 1PQ Glasgow
    Pacific Quay
    United Kingdom
    Secretario
    G51 1PQ Glasgow
    Pacific Quay
    United Kingdom
    British118367070001
    WATT, William George
    G51 1PQ Glasgow
    Pacific Quay
    United Kingdom
    Director
    G51 1PQ Glasgow
    Pacific Quay
    United Kingdom
    ScotlandBritishGroup Finance Director72664400006
    WOODWARD, Robert Stanley Lawrence
    Crawfordston Farm
    Maybole
    KA19 7JS Ayrshire
    Director
    Crawfordston Farm
    Maybole
    KA19 7JS Ayrshire
    ScotlandBritishCompany Director122562020001
    CLARKE, Sara
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    Secretario
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    BritishChartered Management Accountan77963580002
    DAVIDSON, Dawn
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Secretario
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British51065860001
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Secretario
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    British72256160002
    KINLOCH, Don Johnstone
    72 Bailie Drive
    Bearsden
    G61 3HU Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    72 Bailie Drive
    Bearsden
    G61 3HU Glasgow
    Lanarkshire
    British496580001
    LAWRIE, Sheelagh Jane
    3 Havelock Street
    Dowanhill
    G11 5JB Glasgow
    Secretario
    3 Havelock Street
    Dowanhill
    G11 5JB Glasgow
    British39564140001
    ALEXANDER, Kenneth John Wilson, Sir
    9 West Shore
    Pittenweem
    KY10 2NU Anstruther
    Fife
    Director
    9 West Shore
    Pittenweem
    KY10 2NU Anstruther
    Fife
    BritishCompany Director11751070001
    BLACKIE, Kenneth
    84 Boghead Road
    Kirkintilloch
    G66 4EN Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    84 Boghead Road
    Kirkintilloch
    G66 4EN Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector Of Resource557080001
    BOYD, Gavin, Doctor
    Tigh Geal 6 Milton Hill
    Milton
    G82 2TS Dumbarton
    Director
    Tigh Geal 6 Milton Hill
    Milton
    G82 2TS Dumbarton
    BritishSolicitor557090001
    BROWN, William
    Gean House 4a Horseshoe Road
    Bearsden
    G61 2ST Glasgow
    Scotland
    Director
    Gean House 4a Horseshoe Road
    Bearsden
    G61 2ST Glasgow
    Scotland
    BritishChairman312700003
    BUCHANAN-SMITH, Robin Dunlop, Rev
    Isle Of Eriska
    Ledaig
    PA37 1SD Connel
    Argyll
    Director
    Isle Of Eriska
    Ledaig
    PA37 1SD Connel
    Argyll
    BritishHotelier557100001
    CADBURY, Peter Hugh George
    9 Selwood Terrace
    South Kensington
    SW7 3QN London
    Director
    9 Selwood Terrace
    South Kensington
    SW7 3QN London
    BritishBanker38861790001
    CHILTON, Alan
    The Old Rectory
    North Cadbury
    BA22 7DS Yeovil
    Somerset
    Director
    The Old Rectory
    North Cadbury
    BA22 7DS Yeovil
    Somerset
    BritishDirector Of Sales & Marketing61157800001
    COOK, Stephen Sands
    8 Culford Gardens
    SW3 2ST London
    Director
    8 Culford Gardens
    SW3 2ST London
    BritishSolicitor73000530001
    CRUICKSHANK, Donald Gordon, Sir
    17 Clareville Grove
    SW7 5AU London
    Director
    17 Clareville Grove
    SW7 5AU London
    EnglandBritishChairman38060360001
    DUNNETT, Dorothy
    87 Colinton Road
    EH10 5DF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    87 Colinton Road
    EH10 5DF Edinburgh
    Midlothian
    BritishNovelist & Portrait Painter557120001
    EMSLIE, Donald Gordon
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    Director
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    ScotlandBritishDirector61177720002
    FLANAGAN, Andrew Henry
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishDirector42787120004
    FRASER, Campbell, Sir
    Silver Birches 4 Silver Lane
    CR8 3HG Purley
    Surrey
    Director
    Silver Birches 4 Silver Lane
    CR8 3HG Purley
    Surrey
    BritishChairman Of Director39210080001
    FRASER, Charles Annand, Sir
    Shepherd House
    EH21 7TH Inveresk
    Midlothian
    Director
    Shepherd House
    EH21 7TH Inveresk
    Midlothian
    BritishSolicitor35546730001
    GALLAGHER, Eileen
    12-38 Speirs Wharf
    Port Dundas
    G4 9TB Glasgow
    Director
    12-38 Speirs Wharf
    Port Dundas
    G4 9TB Glasgow
    BritishDirector58989370002
    GROSSART, Angus Mcfarlane Mcleod, Sir
    64 Northumberland Street
    EH3 6JE Edinburgh
    Director
    64 Northumberland Street
    EH3 6JE Edinburgh
    United KingdomBritishCompany Director159850001
    HARRISON, Fiona Mary
    15 Bishops Court
    Bishops Bridge Road
    W2 6BE London
    Director
    15 Bishops Court
    Bishops Bridge Road
    W2 6BE London
    BritishDirector40555070002
    HUDSON, Desmond Gerard
    Lindale Off Lampson Road
    G63 9PD Killearn
    Director
    Lindale Off Lampson Road
    G63 9PD Killearn
    United KingdomBritishManaging Director32094360003
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Director
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritishFinance Director72256160002
    HYDE, Pauline Patricia
    38 Lower Belgrave Street
    SW1W 0LN London
    Director
    38 Lower Belgrave Street
    SW1W 0LN London
    BritishCompany Director557130001
    JENKINS, Charles Blair
    9 Fotheringay Road
    G41 4LZ Glasgow
    Director
    9 Fotheringay Road
    G41 4LZ Glasgow
    ScotlandScottishDirector Of Broadcasting84609780002
    KINLOCH, Don Johnstone
    72 Bailie Drive
    Bearsden
    G61 3HU Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    72 Bailie Drive
    Bearsden
    G61 3HU Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector Of Finance496580001
    LAIRD, Gavin Harry, Sir
    9 Cleveden House
    Holmbury Park
    BR1 2WG Bromley
    Kent
    Director
    9 Cleveden House
    Holmbury Park
    BR1 2WG Bromley
    Kent
    BritishGeneral Secretary Amalgamated Engineering Union127153740001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    BritishAccountant28242190001
    MACDONALD, Angus John
    11 Great Western Terrace
    G12 0UP Glasgow
    Director
    11 Great Western Terrace
    G12 0UP Glasgow
    BritishDirector4120001
    MACLEOD, Calum Alexander, Dr
    6 Westfield Terrace
    AB25 2RU Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    6 Westfield Terrace
    AB25 2RU Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishAdvocate1085020001
    MOFFAT, Alistair Murray
    2 Braidburn Terrace
    EH10 6ES Edinburgh
    Director
    2 Braidburn Terrace
    EH10 6ES Edinburgh
    BritishDirector331890001

    ¿Tiene DAWN CHORUS (HOLDINGS) alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental security agreement
    Creado el 25 jun 2003
    Entregado el 27 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under each finance document
    Breve descripción
    First fixed charge and legal mortgage over all estates or interests in the property situated on the 4TH floor of 16 old bond street, london.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 jun 2003Registro de un cargo (410)
    • 02 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 15 abr 2003
    Entregado el 22 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    30A brunswick road, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 abr 2003Registro de un cargo (410)
    • 02 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 04 abr 2003
    Entregado el 17 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage over "english property"; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 abr 2003Registro de un cargo (410)
    • 02 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 31 jul 2002
    Entregado el 02 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The obligations as contained in the finance document
    Breve descripción
    30A brunswick road, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 ago 2002Registro de un cargo (410)
    • 10 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 18 jul 2002
    Entregado el 31 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage over property defined in the schedule; various fixed charges as defined in the schedule attached to the mortgage document; floating charge over all assets.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 2002Registro de un cargo (410)
    • 10 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0