MICROCENTRE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MICROCENTRE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC066117 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MICROCENTRE LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra MICROCENTRE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MICROCENTRE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MICRO CENTRE (COMPLETE MICRO SYSTEMS) LIMITED | 23 oct 1978 | 23 oct 1978 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MICROCENTRE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MICROCENTRE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 6 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Centrum Business Centre Suite No. 4a 38 Queen Street Glasgow G1 3DX Scotland a 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG el 18 abr 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 dic 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 abr 2018 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 30 abr 2019 au 31 mar 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Michael Noble como director el 06 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Stephen James Callaghan el 06 ago 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 30 abr 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Northgate Mill Road Industrial Estate Linlithgow West Lothian EH49 7SF a The Centrum Business Centre Suite No. 4a 38 Queen Street Glasgow G1 3DX el 29 ene 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 dic 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Ian Michael Noble como director el 06 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Coll como director el 06 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen James Callaghan como director el 10 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David John Meaden como director el 10 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de David John Meaden como director el 22 dic 2014 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Andrew Coll como director el 22 dic 2014 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Robert Stier como director el 22 dic 2014 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel William Schenck como secretario el 22 dic 2014 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MICROCENTRE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
| CALLAGHAN, Stephen James | Director | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 201347710052 | |||||||||
| MCDONNELL, James | Secretario | 2 Carwood Crescent BT36 5LT Glengormley County Antrim N.Ireland | British | 143194930001 | ||||||||||
| NUNN, Carol Jayne | Secretario | Boundary Way HP2 7HU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 101872040001 | ||||||||||
| RICHARDSON, John David | Secretario | Mill Road Industrial Estate EH49 7SF Linlithgow C/O Northgate West Lothian | British | 128558470001 | ||||||||||
| ROBERTSON, Michael Andrew | Secretario | 2 Robins Wood CA3 9FN Carlisle Cumbria | British | 75632700001 | ||||||||||
| SCHENCK, Daniel William | Secretario | Mill Road Industrial Estate EH49 7SF Linlithgow C/O Northgate West Lothian | Usa | 181204960001 | ||||||||||
| THOM, Ian | Secretario | Copsewood 60 Drumbo Road BT27 5TX Lisburn Antrim | British | 156536170001 | ||||||||||
| TURNBULL, James Douglas | Secretario | Inverallan 62 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | British | 538440004 | ||||||||||
| WISHART, Doreen Pamela Craig | Secretario | 16 Kingsburgh Road EH12 6DZ Edinburgh Midlothian | British | 98700001 | ||||||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Director | Mill Road Industrial Estate EH49 7SF Linlithgow C/O Northgate West Lothian | United States | American | 165900220001 | |||||||||
| BAILES, Robert | Director | 4 Cambridge Avenue BT42 2EN Ballymena County Antrim | British | 71052640001 | ||||||||||
| BRADY, Richard Noel | Director | Scrabo Lodge, 179-181 Scrabo Road BT23 4SJ Newtownards County Down | Northern Ireland | British | 142958140001 | |||||||||
| COLL, Andrew | Director | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 237260100001 | |||||||||
| CREIGHTON, Steven Henry | Director | 4 Croft Meadows BT18 0LB Holywood County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | 143021640001 | |||||||||
| GREGG, Norman Campbell Minnis | Director | 1 Brooklands Park BT23 4XY Newtownards County Down | Northern Ireland | British | 71052540001 | |||||||||
| JOHNSTONE, Grace | Director | 6 Grosvenor Crescent Hillhead G12 9AE Glasgow | British | 48366920003 | ||||||||||
| MCCANN, Robert | Director | 3 Green Acres BT36 6NL Newtownabbey County Antrim | British | 71196070001 | ||||||||||
| MEADEN, David John | Director | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 193740420001 | |||||||||
| NEVILLE, Geoffrey Leslie | Director | 53 Church Road Abbots Leigh BS8 3QU Bristol Avon | United Kingdom | British | 39989270002 | |||||||||
| NOBLE, Ian Michael | Director | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 199843940001 | |||||||||
| PRINGLE, Aileen | Director | 12 Belgrave Crescent EH4 3AH Edinburgh | United Kingdom | British | 764870001 | |||||||||
| PRINGLE, Ann Isobel | Director | 5 Royal Drive ML3 7DJ Hamilton Lanarkshire | British | 538430002 | ||||||||||
| PRINGLE, John Stock | Director | Upper Carbarns Farm Netherton ML2 0RW Wishaw | British | 355710003 | ||||||||||
| ROBERTSON, Michael Andrew | Director | 2 Robins Wood CA3 9FN Carlisle Cumbria | United Kingdom | British | 75632700001 | |||||||||
| ROUXEL, Norman Hugh | Director | 37 Scotland Street EH3 6PY Edinburgh Midlothian | British | 349250001 | ||||||||||
| STIER, John Robert | Director | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78901530003 | |||||||||
| STONE, Christopher Michael Renwick | Director | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 66955690003 | |||||||||
| TURNBULL, James Douglas | Director | Inverallan 62 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | British | 538440004 | ||||||||||
| WISHART, David | Director | 16 Kingsburgh Road EH12 6DZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 98690001 | |||||||||
| WISHART, Doreen Pamela Craig | Director | 16 Kingsburgh Road EH12 6DZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 98700001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MICROCENTRE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northgate Public Services (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MICROCENTRE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 26 mar 1998 Entregado el 31 mar 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 20 sandyford place,glasgow. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 07 ago 1979 Entregado el 15 ago 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene MICROCENTRE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0