SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa SC071516
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Peregrine House Peregrine Road
    Westhill Business Park, Westhill
    AB32 6JL Aberdeenshire
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SPS-AFOS INTERNATIONAL LIMITED05 jun 200005 jun 2000
    AFOS INTERNATIONAL LIMITED15 oct 199215 oct 1992
    ABERDEEN FILTRATION AND OILFIELD SERVICES LIMITED21 may 198021 may 1980

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2018
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2019
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Misceláneos

    Confirmation of transfer of assets and liabilities
    1 páginasMISC

    Misceláneos

    Notification from overseas registry of completion of merger
    3 páginasMISC

    Misceláneos

    Court order re completion of cross border merger
    3 páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    105 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Approved draft terms of cross border merger 10/12/2018
    RES13

    Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Misceláneos

    CB01 – cross border merger notice
    142 páginasMISC

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ian Jack como director el 10 ago 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr David Marsh como director el 03 nov 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Simon Smoker como director el 03 nov 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ryan Alexander Kidd como director el 03 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    16 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Ryan Alexander Kidd el 01 may 2015

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Simon Smoker como secretario el 01 ene 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Pauline Droy Moore como secretario el 31 dic 2015

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 30 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 dic 2015

    Estado de capital el 11 dic 2015

    • Capital: GBP 250,000
    SH01

    Cambio de datos del secretario Pauline Droy Moore el 23 oct 2015

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Ian Jack el 23 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    13 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ a Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL el 01 may 2015

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Ryan Alexander Kidd como director el 01 ene 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jim Andrews como director el 01 ene 2015

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMOKER, Simon
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Secretario
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    203967800001
    MARSH, David
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish171331520001
    SMOKER, Simon
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish134158640002
    COWAN, Raymond Andrew William
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretario
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British65217400001
    DROY MOORE, Pauline
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Secretario
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    158497360002
    GORMLEY, Donald
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Secretario
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    British105532790001
    GRIFFIN, Thomas Eugene
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Secretario
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Lawyer14300020004
    LEDINGHAM CHALMERS
    1 Golden Square
    AB10 1HA Aberdeen
    Secretario corporativo
    1 Golden Square
    AB10 1HA Aberdeen
    73896680007
    ANDREWS, Jim
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish163190540001
    ARNOLD-GRIFFIN, Sandra Gay
    Menie House
    Balmedie
    Aberdeen
    Director
    Menie House
    Balmedie
    Aberdeen
    American14300010002
    COWAN, Raymond Andrew William
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish65217400001
    ELLIS, Richard John Muir
    Burnside
    Kingsford Mews
    AB33 8HN Alford
    Aberdeenshire
    Scotland
    Director
    Burnside
    Kingsford Mews
    AB33 8HN Alford
    Aberdeenshire
    Scotland
    British82194530001
    EMSLIE, Peter Forbes
    Tantallon Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Director
    Tantallon Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    British24490001
    GIBB, William Ian Alexander
    St Eunans Road
    AB34 5HH Aboyne
    Kinnaird
    Aberdeenshire
    Director
    St Eunans Road
    AB34 5HH Aboyne
    Kinnaird
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish103544230002
    GORMLEY, Donald
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    ScotlandBritish105532790001
    GRIFFIN, Thomas Eugene
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Director
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Lawyer14300020004
    HENDERSON, Jeremy Neil
    Tillyfour House
    Tough
    AB33 8DX Alford
    Aberdeenshire
    Director
    Tillyfour House
    Tough
    AB33 8DX Alford
    Aberdeenshire
    British73430001
    HOWLETT, Paul David
    234 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9PB Aberdeen
    Director
    234 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9PB Aberdeen
    British55761030001
    JACK, Ian
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    ScotlandBritish103412640012
    KIDD, Ryan Alexander
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ Gatwick
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ Gatwick
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    ScotlandBritish192568420001
    MACKENZIE, Peter
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    British114652960002
    WILLIAMS, Glynn Richard
    The Old Post Office
    Easton
    SO21 1EF Winchester
    Hampshire
    Director
    The Old Post Office
    Easton
    SO21 1EF Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish36481970003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Peregrine Road
    Westhill Business Park, Westhill
    AB32 6JL Aberdeenshire
    Peregrine House
    Scotland
    Scotland
    06 abr 2016
    Peregrine Road
    Westhill Business Park, Westhill
    AB32 6JL Aberdeenshire
    Peregrine House
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom (Scotland)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc204919
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 24 may 2000
    Entregado el 01 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee
    Transacciones
    • 01 jun 2000Registro de un cargo (410)
    • 07 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 24 may 2000
    Entregado el 01 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Qhe Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee
    Transacciones
    • 01 jun 2000Registro de un cargo (410)
    • 07 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 07 jul 1999
    Entregado el 14 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 14 jul 1999Registro de un cargo (410)
    • 07 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 28 jul 1997
    Entregado el 07 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The farm and lands of leyton, belhelvie, aberdeen....... See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1997Registro de un cargo (410)
    • 08 jun 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 14 feb 1994
    Entregado el 28 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    (1ST) 2 areas of ground in belhelvie, aberdeenshire being enclosure numbers 0045, 0038, 0035, 3819, 6033, 8124, 8700, 8500, 8100, 7212 & 5719 (2ND) strip of ground 12FT wide along east most boundary of (1ST) (3RD) strip of woodland dividing areas formerly numbered 1233 and 1234. but always excluding from (1ST) the accesss road running along southwest boundary.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 28 feb 1994Registro de un cargo (410)
    • 08 jun 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 14 feb 1994
    Entregado el 28 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    29 acres at menie house, balmedie, aberdeenshire.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 28 feb 1994Registro de un cargo (410)
    • 08 jun 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 05 oct 1993
    Entregado el 19 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    58.31 acres comprising enclosures number 1234,1235, 1237, 1238, 1239 & 1241 part of the lands and farm of hill of menie in the parish of belhelvie aberdeenshire.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 oct 1993Registro de un cargo (410)
    • 28 feb 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (419b)
    • 08 jun 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 16 dic 1991
    Entregado el 06 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    81
    Breve descripción
    1.27 acres comprising the mansion house of mernie balmedie aberdeen.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 ene 1991Registro de una carga
    • 08 jun 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Letter of agreement
    Creado el 11 mar 1985
    Entregado el 19 mar 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All sums standing or that may stand to the credit of any of the company's accounts with the bank and all sums deposited or to be deposited by the company with the bank whether denominated in sterling or otherwise and irrespective of the term of such deposits.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 mar 1985Registro de una carga
    • 15 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 11 mar 1981
    Entregado el 11 mar 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 mar 1981Registro de una carga
    • 09 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 10 feb 1981
    Entregado el 27 feb 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 feb 1981Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0