STIELL INFRAMAN LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | STIELL INFRAMAN LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC083991 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STIELL INFRAMAN LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra STIELL INFRAMAN LIMITED?
| Dirección de la sede social | Atria One 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STIELL INFRAMAN LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| STIELL PROCESS ENGINEERING LIMITED | 28 sept 1998 | 28 sept 1998 |
| FRANKLIN CONTROLS LIMITED | 19 jul 1983 | 19 jul 1983 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STIELL INFRAMAN LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STIELL INFRAMAN LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Cese del nombramiento de Francis Robin Herzberg como director el 12 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 10 dic 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Westley Maffei como director el 10 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Lee James Mills como director el 07 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Westley Maffei el 01 oct 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Westley Maffei el 01 oct 2018 | 1 páginas | CH03 | ||
Cambio de datos del director Mr Lee James Mills el 01 oct 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Francis Robin Herzberg el 01 oct 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 4 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de New Alderston House Strathclyde Business Park 3 Dove Wynd Bellshill Scotland ML4 3FB Scotland a Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX el 31 may 2018 | 1 páginas | AD01 | ||
Modification des détails de Carillion (Ambs) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Richard John Howson como director el 15 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 11 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Westley Maffei como director el 01 jul 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Westley Maffei como secretario el 01 jul 2017 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Timothy Francis George como secretario el 30 jun 2017 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Timothy Francis George como director el 30 jun 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Fenick House 1 Lister Way Hamilton International Technology Park Blantyre Glasgow G72 0FT a New Alderston House Strathclyde Business Park 3 Dove Wynd Bellshill Scotland ML4 3FB el 19 jun 2017 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Zafar Iqbal Khan el 01 ene 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de STIELL INFRAMAN LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALD, James | Secretario | Rivendell 6 Gowanside Place ML8 5UN Carluke Lanarkshire | British | 981650002 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Secretario | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| GRICE, Ian Michael | Secretario | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | British | 44883010002 | ||||||
| JACKSON, Andrew Philip | Secretario | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | British | 7921750002 | ||||||
| JARVIE, Elizabeth Russell Hamilton | Secretario | 14 Green Ferns Blackwood ML11 9XT Kirkmuirhill South Lanarkshire | British | 87808480001 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Secretario | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | 235170520001 | |||||||
| MEIKLE, Gillian | Secretario | 21 Vere Terrace Kirkmuirhill ML11 9YX Lanark | British | 37683380001 | ||||||
| AM SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 28265670010 | |||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretario designado corporativo | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||
| ADAM, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| ALLAN, William Macdonald | Director | Hyndford Lea House 409 Hyndford Park ML11 8SQ Lanark Lanarkshire | British | 632640004 | ||||||
| BARRETT, James Desmond | Director | 31 Meldrum Mains Glenmavis ML6 0QQ Airdrie Lanarkshire | British | 656260001 | ||||||
| DONALD, James | Director | Rivendell 6 Gowanside Place ML8 5UN Carluke Lanarkshire | British | 981650002 | ||||||
| ENGSTROM, Bertil Staffan, Mr. | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | Swedish | 165350570001 | |||||
| GEORGE, Timothy Francis | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 24075160004 | |||||
| GIBSON, David Heron | Director | 502 Darvel Road Caldermill ML10 6QD Strathaven Lanarkshire | British | 36214750001 | ||||||
| HERZBERG, Francis Robin | Director | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | England | British | 52429400001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| JARVIE, Elizabeth Russell Hamilton | Director | 14 Green Ferns Blackwood ML11 9XT Kirkmuirhill South Lanarkshire | British | 87808480001 | ||||||
| JARVIE, Robert Franklin | Director | 14 Green Ferns ML11 9XT Blackwood South Lanarkshire | Scotland | British | 87222030001 | |||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| LOCH, William Alexander | Director | The Bothy No3 Manor Farm MK18 4JX Barton Hartshorn Buckinghamshire | British | 58993330002 | ||||||
| MAFFEI, Westley Anthony | Director | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | United Kingdom | British | 189962560002 | |||||
| MCGILVRAY, Craig Mathew | Director | 43 Camphill Avenue G41 3AX Glasgow | British | 58993260001 | ||||||
| MCNULTY, Noel | Director | 27 Skirving Street G41 3AB Glasgow | British | 76172610001 | ||||||
| MERCER, Emma Louise | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 163383420001 | |||||
| MILLS, Lee James | Director | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| SMITH, Derek | Director | 4 Carnbroe Road ML5 4SG Coatbridge Lanarkshire | British | 71755410001 | ||||||
| SMYTH, Edward George | Director | Wormley Hill House Church Lane EN10 7QQ Wormley Herts | United Kingdom | British | 87750910001 | |||||
| AM NOMINEES LIMITED | Director corporativo | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 34427260007 | |||||||
| AM SECRETARIES LIMITED | Director corporativo | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 28265670010 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de STIELL INFRAMAN LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion (Ambs) Limited | 06 abr 2016 | 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh Atria One United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene STIELL INFRAMAN LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creado el 28 abr 1994 Entregado el 13 may 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creado el 06 abr 1994 Entregado el 27 abr 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £20,000 | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 01 jul 1988 Entregado el 11 jul 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0