STIELL INFRAMAN LIMITED

STIELL INFRAMAN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTIELL INFRAMAN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC083991
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STIELL INFRAMAN LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra STIELL INFRAMAN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STIELL INFRAMAN LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    STIELL PROCESS ENGINEERING LIMITED28 sept 199828 sept 1998
    FRANKLIN CONTROLS LIMITED19 jul 198319 jul 1983

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STIELL INFRAMAN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STIELL INFRAMAN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cese del nombramiento de Francis Robin Herzberg como director el 12 dic 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 10 dic 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Westley Maffei como director el 10 dic 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Lee James Mills como director el 07 dic 2018

    1 páginasTM01

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr Westley Maffei el 01 oct 2018

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Westley Maffei el 01 oct 2018

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Lee James Mills el 01 oct 2018

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Francis Robin Herzberg el 01 oct 2018

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    4 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de New Alderston House Strathclyde Business Park 3 Dove Wynd Bellshill Scotland ML4 3FB Scotland a Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX el 31 may 2018

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Carillion (Ambs) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2018

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Richard John Howson como director el 15 ene 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 11 sept 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Westley Maffei como director el 01 jul 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Westley Maffei como secretario el 01 jul 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Timothy Francis George como secretario el 30 jun 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Timothy Francis George como director el 30 jun 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    5 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Fenick House 1 Lister Way Hamilton International Technology Park Blantyre Glasgow G72 0FT a New Alderston House Strathclyde Business Park 3 Dove Wynd Bellshill Scotland ML4 3FB el 19 jun 2017

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Zafar Iqbal Khan el 01 ene 2017

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de STIELL INFRAMAN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DONALD, James
    Rivendell 6 Gowanside Place
    ML8 5UN Carluke
    Lanarkshire
    Secretario
    Rivendell 6 Gowanside Place
    ML8 5UN Carluke
    Lanarkshire
    British981650002
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Secretario
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    British38750850004
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British24075160004
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    Secretario
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    British44883010002
    JACKSON, Andrew Philip
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    Secretario
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    British7921750002
    JARVIE, Elizabeth Russell Hamilton
    14 Green Ferns
    Blackwood
    ML11 9XT Kirkmuirhill
    South Lanarkshire
    Secretario
    14 Green Ferns
    Blackwood
    ML11 9XT Kirkmuirhill
    South Lanarkshire
    British87808480001
    MAFFEI, Westley
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Secretario
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    235170520001
    MEIKLE, Gillian
    21 Vere Terrace
    Kirkmuirhill
    ML11 9YX Lanark
    Secretario
    21 Vere Terrace
    Kirkmuirhill
    ML11 9YX Lanark
    British37683380001
    AM SECRETARIES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Secretario corporativo
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    28265670010
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretario designado corporativo
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    ADAM, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish67133560004
    ALLAN, William Macdonald
    Hyndford Lea House
    409 Hyndford Park
    ML11 8SQ Lanark
    Lanarkshire
    Director
    Hyndford Lea House
    409 Hyndford Park
    ML11 8SQ Lanark
    Lanarkshire
    British632640004
    BARRETT, James Desmond
    31 Meldrum Mains
    Glenmavis
    ML6 0QQ Airdrie
    Lanarkshire
    Director
    31 Meldrum Mains
    Glenmavis
    ML6 0QQ Airdrie
    Lanarkshire
    British656260001
    DONALD, James
    Rivendell 6 Gowanside Place
    ML8 5UN Carluke
    Lanarkshire
    Director
    Rivendell 6 Gowanside Place
    ML8 5UN Carluke
    Lanarkshire
    British981650002
    ENGSTROM, Bertil Staffan, Mr.
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandSwedish165350570001
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish24075160004
    GIBSON, David Heron
    502 Darvel Road
    Caldermill
    ML10 6QD Strathaven
    Lanarkshire
    Director
    502 Darvel Road
    Caldermill
    ML10 6QD Strathaven
    Lanarkshire
    British36214750001
    HERZBERG, Francis Robin
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    EnglandBritish52429400001
    HOWSON, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish147650310001
    JARVIE, Elizabeth Russell Hamilton
    14 Green Ferns
    Blackwood
    ML11 9XT Kirkmuirhill
    South Lanarkshire
    Director
    14 Green Ferns
    Blackwood
    ML11 9XT Kirkmuirhill
    South Lanarkshire
    British87808480001
    JARVIE, Robert Franklin
    14 Green Ferns
    ML11 9XT Blackwood
    South Lanarkshire
    Director
    14 Green Ferns
    ML11 9XT Blackwood
    South Lanarkshire
    ScotlandBritish87222030001
    KHAN, Zafar Iqbal
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish195408780001
    LOCH, William Alexander
    The Bothy
    No3 Manor Farm
    MK18 4JX Barton Hartshorn
    Buckinghamshire
    Director
    The Bothy
    No3 Manor Farm
    MK18 4JX Barton Hartshorn
    Buckinghamshire
    British58993330002
    MAFFEI, Westley Anthony
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    United KingdomBritish189962560002
    MCGILVRAY, Craig Mathew
    43 Camphill Avenue
    G41 3AX Glasgow
    Director
    43 Camphill Avenue
    G41 3AX Glasgow
    British58993260001
    MCNULTY, Noel
    27 Skirving Street
    G41 3AB Glasgow
    Director
    27 Skirving Street
    G41 3AB Glasgow
    British76172610001
    MERCER, Emma Louise
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandBritish163383420001
    MILLS, Lee James
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    United KingdomBritish53951880001
    SMITH, Derek
    4 Carnbroe Road
    ML5 4SG Coatbridge
    Lanarkshire
    Director
    4 Carnbroe Road
    ML5 4SG Coatbridge
    Lanarkshire
    British71755410001
    SMYTH, Edward George
    Wormley Hill House
    Church Lane
    EN10 7QQ Wormley
    Herts
    Director
    Wormley Hill House
    Church Lane
    EN10 7QQ Wormley
    Herts
    United KingdomBritish87750910001
    AM NOMINEES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Director corporativo
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    34427260007
    AM SECRETARIES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Director corporativo
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    28265670010

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de STIELL INFRAMAN LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    United Kingdom
    06 abr 2016
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc020258
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene STIELL INFRAMAN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 28 abr 1994
    Entregado el 13 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lanarkshire Development Agency
    Transacciones
    • 13 may 1994Registro de un cargo (410)
    • 05 sept 1994Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 07 sept 1994Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 24 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 06 abr 1994
    Entregado el 27 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £20,000
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Strathclyde Regional Council
    Transacciones
    • 27 abr 1994Registro de un cargo (410)
    • 13 sept 1994Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 16 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 01 jul 1988
    Entregado el 11 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 jul 1988Registro de una carga
    • 12 sept 1994Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 02 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0