WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC089533 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Leven House 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED | 18 jun 1991 | 18 jun 1991 |
| WOODEND LEASING LIMITED | 04 sept 1984 | 04 sept 1984 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 05 mar 2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 feb 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 feb 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Joanne Sarah Finch como director el 26 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 feb 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Lochside House 7 Lochside Avenue Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9DJ Scotland* el 18 sept 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Nigel Evans como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Martin Purkess como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 feb 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Diane Mcintyre como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Schäfer como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | 75473330004 | |||||||
| EVANS, David Nigel | Director | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 134975040001 | |||||
| MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Director | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 173703620001 | |||||
| BAIRD, Brian Alexander | Secretario | 4 Cheviot Drive G77 5AS Glasgow | British | 95529070001 | ||||||
| MACLEOD, David | Secretario | 12 Glebe Road Newton Mearns G77 6DU Glasgow | British | 32696310001 | ||||||
| MCINTYRE, Colin | Secretario | 473 Clarkston Road G44 3LW Glasgow Lanarkshire | British | 732300001 | ||||||
| PRENTICE, Edward Duncan | Secretario | 72 Lymekilns Road East Kilbride G74 4TU Glasgow Lanarkshire | British | 72432810001 | ||||||
| SCOTT, Stephen Roy | Secretario | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||
| QUEENSFERRY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HG Edinburgh | 38051430002 | |||||||
| ALLAN, William | Director | Shernfold Meadows Wadhurst Road TN3 9EH Frant East Sussex | Uk | British | 111131550001 | |||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Director | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | British | 123612980001 | ||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Director | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||
| CHESWORTH, Paul | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||
| EVANS, Mark | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Director | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||
| FORD, John Joseph | Director | 30 Gildale Werrington PE4 6QY Peterborough Cambridgeshire | British | 78094110001 | ||||||
| GRAY, Ian | Director | 61 Bathurst Mews W2 2SB London | United Kingdom | British | 50246030004 | |||||
| HADDEN, Mervyn Alexander | Director | Chantry Cottage The Warren KT24 5RH East Horsley Surrey | British | 94655490001 | ||||||
| HADDOW, Neil Scott | Director | 104 Mearns Road Clarkston G76 7UP Glasgow | British | 53774190001 | ||||||
| HALFORD, Andrew Nigel | Director | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | 33951180005 | ||||||
| HAULDSWORTH, June | Director | 16 Greenhill Bishopbriggs G64 1LE Glasgow Lanarkshire | British | 1002880001 | ||||||
| HILLS, Kenneth Cumming | Director | 49 Spottiswoode Street EH9 1DQ Edinburgh Midlothian | British | 65152940001 | ||||||
| HOULDSWORTH, June | Director | Baron Hill Nursery 86 Hunthill Road High Blantyre G72 9UY Glasgow | United Kingdom | British | 1376720001 | |||||
| KEY, Matthew David | Director | Yardley School Lane Seer Green HP9 2QJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 62981720001 | ||||||
| LEE, Simon Christopher | Director | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| LEE, Simon Christopher | Director | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| MATTHEWS, Roderick Alfred | Director | Aros House Rhu G84 8NJ Helensburgh Dunbartonshire | British | 74872510003 | ||||||
| MCALOON, William Gerard | Director | 10 Jacks View West Kilbride KA23 9HX Ayshire Ayrshire | British | 108756350001 | ||||||
| MCLEAN, Gregory Joseph | Director | 3 Princes Terrace Dowanhill G12 9JW Glasgow | American | 33612180002 | ||||||
| NOWAK, Thomas, Dr | Director | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | United Kingdom | German | 174443800001 | |||||
| PRENTICE, Edward Duncan | Director | 72 Lymekilns Road East Kilbride G74 4TU Glasgow Lanarkshire | British | 72432810001 | ||||||
| PURKESS, Martin John | Director | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | England | British | 139360020001 | |||||
| READ, Nicholas Jonathan | Director | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 87149560001 | |||||
| REGAN, William Paul | Director | 7 Glenpark Avenue G46 7JE Glasgow Renfrewshire Uk | British | 48839480001 | ||||||
| RUSSELL, Ian Simon Macgregor | Director | 73 Braid Avenue EH10 6ED Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 38783050003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodend Holdings Limited | 06 abr 2016 | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 05 abr 1991 Entregado el 15 abr 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 13 oct 1988 Entregado el 18 oct 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0