EDI (INDUSTRIAL) LIMITED

EDI (INDUSTRIAL) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEDI (INDUSTRIAL) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC119939
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Waverley Court
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ENTERPRISE EDINBURGH SERVICES LIMITED10 ene 199010 ene 1990
    PACIFIC SHELF 279 LIMITED04 sept 198904 sept 1989

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Modification des détails de The Edi Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 jun 2018

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Cllr Lezley Marion Cameron como director el 11 jul 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Cllr Iain Whyte como director el 11 jul 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Eric Weir Adair como director el 30 jun 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Cllr Katherine Rosa Campbell como director el 11 jul 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    7 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 3 Cockburn Street Edinburgh EH1 1QB Scotland a Waverley Court 4 East Market Street Edinburgh EH8 8BG el 19 jun 2018

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    7 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 7/9 North St. David Street Edinburgh EH2 1AW a 3 Cockburn Street Edinburgh EH1 1QB el 24 jul 2016

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 10 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 ene 2016

    Estado de capital el 19 ene 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 ene 2015

    Estado de capital el 12 ene 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    7 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Dolphin House 4 Hunter Square Edinburgh EH1 1QW* el 08 abr 2014

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 10 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 ene 2014

    Estado de capital el 14 ene 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Tom Buchanan como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CAMERON, Lezley Marion, Cllr
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Director
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritish77460160001
    CAMPBELL, Katherine Rosa
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Director
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    United KingdomBritish233686000001
    WHYTE, Iain, Cllr
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Director
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritish148139080002
    BLYTH, William
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    Secretario
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    British514950001
    MCGOWAN, Carol Ann
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    British112664200001
    WILSON, Mary
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Secretario
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    British42188180001
    ADAIR, Eric Weir
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Director
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritish116185430001
    AITCHISON, Thomas Nisbet
    27 Dudley Terrace
    EH6 4QQ Edinburgh
    Director
    27 Dudley Terrace
    EH6 4QQ Edinburgh
    British43674840001
    ANDERSON, Donald Craig
    39 The Spinney
    EH17 7LE Edinburgh
    Midlothian
    Director
    39 The Spinney
    EH17 7LE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish48629740001
    ATKINSON, Elspeth, Dr
    The Rectory 203 Gilmore Place
    EH3 9PN Edinburgh
    Director
    The Rectory 203 Gilmore Place
    EH3 9PN Edinburgh
    British51045490001
    BARRETT, John
    3 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Director
    3 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    British728540001
    BEGG, David, Councillor
    29/9 Castle Terrace
    EH1 2EL Edinburgh
    Director
    29/9 Castle Terrace
    EH1 2EL Edinburgh
    British48777780002
    BLYTH, William
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    Director
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    British514950001
    BUCHANAN, Tom
    Dolphin House
    4 Hunter Square
    EH1 1QW Edinburgh
    Director
    Dolphin House
    4 Hunter Square
    EH1 1QW Edinburgh
    United KingdomBritish123330960001
    CAMERON, Lezley Marion, Cllr
    12/5 Mayfield Terrace
    EH9 1SA Edinburgh
    Director
    12/5 Mayfield Terrace
    EH9 1SA Edinburgh
    ScotlandBritish77460160001
    DALGETY, Susan
    16 Temple Park Crescent
    EH11 1HT Edinburgh
    Director
    16 Temple Park Crescent
    EH11 1HT Edinburgh
    British103240003
    DI CIACCA, John Mark
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    The Red Post
    Fife
    Director
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    The Red Post
    Fife
    United KingdomBritish77111830002
    DREVER, Peng Geik
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    Director
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    Malaysian69597360001
    GEDDES, Keith Taylor
    9 Willowbrae Avenue
    EH8 7HB Edinburgh
    Midlothian
    Director
    9 Willowbrae Avenue
    EH8 7HB Edinburgh
    Midlothian
    British975490001
    GILCHRIST, James
    21 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    Director
    21 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    British318630002
    GILMORE, Sheila
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Director
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    UkBritish27232470001
    GILMORE, Sheila
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Director
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    UkBritish27232470001
    GORRIE, Donald Cameron Easterbrook
    9 Garscube Terrace
    EH12 6BW Edinburgh
    Midlothian
    Director
    9 Garscube Terrace
    EH12 6BW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish76140001
    HINDS, Lesley Adelaide
    4 Easter Drylaw Place
    EH4 2QD Edinburgh
    Lothian
    Director
    4 Easter Drylaw Place
    EH4 2QD Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish3480180001
    HUNTER, Colin Ian
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    Director
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    ScotlandBritish37329910003
    KENNEDY, Sheila
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    Director
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    British35269940001
    KENNEDY, Sheila
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    Director
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    British35269940001
    KEREVAN, George
    Brunstane House South Wing
    Brunstane Road South
    EH15 2NQ Edinburgh
    Director
    Brunstane House South Wing
    Brunstane Road South
    EH15 2NQ Edinburgh
    ScotlandBritish660740002
    LAZAROWICZ, Marek Jerzy
    97 Marchmont Road
    EH9 1HB Edinburgh
    Lothian
    Director
    97 Marchmont Road
    EH9 1HB Edinburgh
    Lothian
    British6335060002
    LOWENBERG, Paul George
    37 Salisbury Road
    EH16 5AA Edinburgh
    Midlothian
    Director
    37 Salisbury Road
    EH16 5AA Edinburgh
    Midlothian
    American70889900001
    MACKAY, Angus John
    84 Liberton Brae
    EH16 6LB Edinburgh
    Director
    84 Liberton Brae
    EH16 6LB Edinburgh
    ScotlandBritish48624810001
    MACKINTOSH, Hugh Frederick Dundas
    204 Dalkeith Road
    EH16 5DT Edinburgh
    Midlothian
    Director
    204 Dalkeith Road
    EH16 5DT Edinburgh
    Midlothian
    British71329550001
    MARSHALL, Robert Alexander
    Flat 1 Silverknowes Road
    3 Silverknowes Road
    EH4 5NX Edinburgh
    Midlothian
    Director
    Flat 1 Silverknowes Road
    3 Silverknowes Road
    EH4 5NX Edinburgh
    Midlothian
    British648950001
    PERRY, Ian
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    Director
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    ScotlandBritish127893650001
    PERRY, Ian
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    Director
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    ScotlandBritish127893650001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    East Market Street
    EH8 8BG
    EH8 8BG Edinburgh
    4
    Scotland
    01 jun 2016
    East Market Street
    EH8 8BG
    EH8 8BG Edinburgh
    4
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalScottish Law
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc110956
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene EDI (INDUSTRIAL) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 26 nov 2008
    Entregado el 03 dic 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Unit 10B kings haugh, peffermill industrial estate, peffermill road, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 dic 2008Registro de un cargo (410)
    • 18 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Standard security
    Creado el 05 feb 2008
    Entregado el 14 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Generally knowns as peffermill industrial estate, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 feb 2008Registro de un cargo (410)
    • 18 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Standard security
    Creado el 05 feb 2008
    Entregado el 14 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Subjects generally known as 7,9,9A,9B,9C,10,11,12,12A,13-15, 16-22, 23 & 24 south gyle crescent, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 feb 2008Registro de un cargo (410)
    • 18 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creado el 29 ene 2008
    Entregado el 01 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transacciones
    • 01 feb 2008Registro de un cargo (410)
    • 18 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Assignation of rents
    Creado el 02 jun 2005
    Entregado el 10 jun 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Breve descripción
    The company's whole right, title, benefit and interest whether at the charge date or in the future to the rental income pursuant to each of the scheduled leases of the property at peffermill industrial estate, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transacciones
    • 10 jun 2005Registro de un cargo (410)
    Assignation of rents
    Creado el 02 jun 2005
    Entregado el 10 jun 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Breve descripción
    The company's whole right, title, benefit and interest whether at the charge date or in the future in and to the rental income in relation to the lease of the property at south gyle crescent, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transacciones
    • 10 jun 2005Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 01 jun 2005
    Entregado el 10 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Breve descripción
    All those subjects at south gyle crescent, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transacciones
    • 10 jun 2005Registro de un cargo (410)
    • 18 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Standard security
    Creado el 01 jun 2005
    Entregado el 10 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Breve descripción
    Those subjects at peffermill industrial estate, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transacciones
    • 10 jun 2005Registro de un cargo (410)
    • 18 ene 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Floating charge
    Creado el 26 may 2005
    Entregado el 10 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transacciones
    • 10 jun 2005Registro de un cargo (410)
    • 12 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0