MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC125204 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED?
- Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
¿Dónde se encuentra MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Crutherland House And Spa Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MACDONALD HOTELS AND RESORTS LIMITED | 10 feb 2004 | 10 feb 2004 |
| MACDONALD HOTELS LIMITED | 04 dic 2003 | 04 dic 2003 |
| MACDONALD HOTELS PLC | 09 ago 1990 | 09 ago 1990 |
| AMBASSADOR HOTELS & LEISURE LIMITED | 02 jul 1990 | 02 jul 1990 |
| ORRMAC (NO:140) LIMITED | 24 may 1990 | 24 may 1990 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 24 sept 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 24 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 26 sept 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 26 sept 2024 | 20 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Robert Gordon Fraser el 12 nov 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Exercice comptable précédent raccourci du 25 sept 2024 au 24 sept 2024 | 1 páginas | AA01 | ||
Cambio de datos del director Mr Robert Gordon Fraser el 15 may 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Hugh Gillies el 15 may 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Iain Gillies el 15 may 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Alteraciones a la garantía flotante SC1252040026 | 104 páginas | 466(Scot) | ||
Alteraciones a la garantía flotante SC1252040025 | 104 páginas | 466(Scot) | ||
Registro de la carga SC1252040026, creada el 21 feb 2025 | 13 páginas | MR01 | ||
Notification de Macdonald Hotels Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 may 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Hsdl Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 may 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Crutherland House and Spa Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ | 1 páginas | AD04 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 sept 2023 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cancelación total de la carga 10 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 7 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC1252040019 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC1252040023 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC1252040018 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 11 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 14 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 9 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 12 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC1252040022 | 1 páginas | MR04 | ||
¿Quiénes son los directivos de MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRASER, Robert Gordon | Director | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 289448940001 | |||||
| GILLIES, Hugh | Director | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | United Kingdom | British | 301475200001 | |||||
| GILLIES, Iain | Director | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 436470002 | |||||
| BUSBY, James George William | Secretario | 4 Murchison Road,Houston Bridge Of Weir PA6 7JU Renfrewshire | British | 584980003 | ||||||
| FRASER, Robert Gordon | Secretario | 1 Glebe Court KA1 3BD Kilmarnock Ayrshire | British | 120322350001 | ||||||
| GILLESPIE, Brendan | Secretario | 56 Blairbeth Road Rutherglen G73 4JQ Glasgow Lanarkshire | British | 65199400001 | ||||||
| PALMER, Alan Charles | Secretario | 7 Earlsgate Brierie Hills PA6 7FB Houston Renfrewshire | British | 89601520001 | ||||||
| ROSS, Mark | Secretario | 58 Kettilstoun Mains EH49 6SL Linlithgow West Lothian | British | 106803450001 | ||||||
| ORR MACQUEEN WS | Secretario designado corporativo | 36 Heriot Row EH3 6ES Edinburgh | 900000160001 | |||||||
| BUSBY, James George William | Director | 16 Fairyknowe Court Bothwell G71 8SZ Glasgow | United Kingdom | British | 584980007 | |||||
| CARTER, Phil | Director | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 291374460001 | |||||
| CHRISTIE, Scott Sommervaille | Director | Gospatric House Bankhead Road Dalmeny EH30 9TT Edinburgh | Scotland | British | 104262520001 | |||||
| CRAWFORD, Guy Lindsay Macintyre | Director | 86 Kingston Hill KT2 7NP Kingston Upon Thames Surrey | British | 77508520001 | ||||||
| DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Director | Cuckoo Meadow Little Shardeloes HP7 0EF Old Amersham Buckinghamshire | England | British | 100598030001 | |||||
| FALLS, Aaron Peter | Director | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 279163090001 | |||||
| FRASER, Robert Gordon | Director | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 120322350003 | |||||
| GILLIES, Iain | Director | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 436470002 | |||||
| GUILE, David Andrew | Director | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | United Kingdom | British | 100133280001 | |||||
| HEMMINGS, Trevor James | Director | The Penthouse Retraite De La Mielle Route De La Haule St Brelade JE3 8BA Jersey Channel Islands | United Kingdom | British | 65090920001 | |||||
| KEARNEY, Douglas Richard | Director | 11 Eastwoodmains Road G46 6QB Glasgow | Scotland | British | 93762430001 | |||||
| LERCHE, James Andrew | Director | Upper Westown Farmhouse Barras AB39 2XU Stonehaven Aberdeenshire | British | 61618300001 | ||||||
| MACDONALD, Angus Donald Mackintosh | Director | 18 Hermitage Drive EH10 6BZ Edinburgh | Scotland | British | 43780001 | |||||
| MACDONALD, Donald John | Director | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian Scotland | Scotland | British | 557590001 | |||||
| MACDONALD, Donald John | Director | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 557590001 | |||||
| MACDONALD, Ruaridh | Director | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 138199130001 | |||||
| MACLEOD, Calum Alexander, Dr | Director | 6 Westfield Terrace AB25 2RU Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 1085020001 | |||||
| MCBURNIE, Jason | Director | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian Scotland | United Kingdom | British | 202600000001 | |||||
| MCGEE, Jeremiah | Director | 5 Knunck Knowles Drive BB7 2JF Clitheroe Lancashire Uk | Irish | 68330590001 | ||||||
| MURRAY, Rodger Grant | Director designado | 24 Moston Terrace Edinburgh | British | 900000170001 | ||||||
| O'CALLAGHAN, Francis | Director | 21 Hamilton Avenue Pollokshields G41 4JG Glasgow | Scotland | British | 557570001 | |||||
| O'NEILL, Tara | Director | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Ireland | Irish | 277153640001 | |||||
| ORR, James Alexander Macconnell | Director | 10 Learmonth Grove EH4 1BP Edinburgh | Scotland | British | 81233650001 | |||||
| PAJARES, Ramon | Director | 38 Pont Street Mews SW1X 0AF London | Spanish | 45733530002 | ||||||
| PAJARES, Ramon | Director | 38 Pont Street Mews SW1X 0AF London | Spanish | 45733530002 | ||||||
| SCOTT, John Hamilton | Director designado | 7 Glengyle Terrace Edinburgh | British | 900000180001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macdonald Hotels Limited | 05 may 2023 | Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ Glasgow Crutherland House And Spa Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Hsdl Nominees Limited | 06 abr 2016 | HX1 2RG Halifax Trinity Road United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0