CB (1994) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CB (1994) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC147754 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CB (1994) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CB (1994) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Tlt Scotland Limited 140 West George Street G2 2HG Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CB (1994) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DRYWOOD LIMITED | 29 nov 1993 | 29 nov 1993 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CB (1994) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 18 ago 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CB (1994) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 7 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Peter Dando como director el 05 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 dic 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2018 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 dic 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 19 ago 2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 dic 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 20 ago 2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Robert Ceidrych Griffiths como director el 30 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 22 ago 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 nov 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 23 ago 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Edward Michael Bashforth como director el 07 oct 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Francesca Appleby como secretario el 07 oct 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Claire Louise Harris como secretario el 07 oct 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 17 ago 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Roger Whiteside como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Neil Robert Ceidruch Griffiths como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Tyrrell como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Claire Louise Harris como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CB (1994) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLEBY, Francesca | Secretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191627520001 | |||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BURNETT, Andrew Alan | Secretario | 38 Templeland Road EH12 8RP Edinburgh Lothian | British | 41431820001 | ||||||
| CROSS, Anthony | Secretario | 38 The Lane Spinkhill S21 3YF Sheffield South Yorkshire | British | 1812400001 | ||||||
| DEEGAN, Jayne | Secretario | 5 Hardstruggle Row Eskdaleside YO22 5ET Sleights North Yorkshire | British | 94870790001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Secretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175482770001 | |||||||
| KAY, Carol Ann | Secretario | 2 The Stackyard Milnathort KY13 9GF Kinross | British | 39277440005 | ||||||
| MILLER, Nicola Jane | Secretario | 27 Hillston Close TS26 0PE Hartlepool | British | 95390370001 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Secretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161623680001 | |||||||
| BRODIES WS | Secretario designado corporativo | 15 Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh | 900000290001 | |||||||
| MACROBERTS CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Scotland | 53781850001 | |||||||
| ARMSTRONG, Michael John | Director | Hunters Gate 56 Palace Road HG4 1HA Ripon North Yorkshire | British | 16410290001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BURNETT, Andrew Alan | Director | 38 Templeland Road EH12 8RP Edinburgh Lothian | Scotland | British | 41431820001 | |||||
| CAMPBELL, Alistair Carnegie | Director designado | 50 Inverleith Place EH3 5QB Edinburgh | British | 900000310001 | ||||||
| DANDO, Stephen Peter | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GRIER, Ian Birrell | Director | 5 Forrest Drive G61 4SJ Bearsden | Scotland | British | 87612170001 | |||||
| GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | England | British | 55975990001 | |||||
| GUILD, David William Alan | Director designado | 1a Belford Park EH4 3DP Edinburgh | British | 900000300001 | ||||||
| GUNDRY, Richard | Director | Holgate Farm 29 The Street Bunwell NR16 1NA Norwich Norfolk | British | 107010490001 | ||||||
| JENKINS, Stuart Nicol | Director | Parkview, 7 Arden Drive Giffnock G46 7AF Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 116623260001 | |||||
| KAY, Robert Duncan | Director | 2 The Stackyard Milnathort KY13 9GF Kinross | British | 62841640001 | ||||||
| KEMP, Deborah Jane | Director | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | 79388130005 | |||||
| LAING, Peter John | Director | 56/1 Timberbush Leith EH6 6QH Edinburgh Midlothian | British | 82725660001 | ||||||
| MACKINNON, David Donaldson | Director | 15 Victoria Road PA19 1LD Gourock | Scotland | British | 116526660001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Director | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| SANDS, John Robert | Director | 11 Falcon Lane Norton TS20 1LS Stockton On Tees | United Kingdom | British | 141561650001 | |||||
| TURNBULL, Ronald | Director | 16 Willow Road Dairy Lane Estate DH4 5QF Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | 63331360001 | ||||||
| WHITESIDE, Roger Mark | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | England | British | 128819260001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CB (1994) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pub.Com Limited | 06 abr 2016 | 140 West George Street G2 2HG Glasgow Tlt Scotland Limited United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CB (1994) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 01 jul 1997 Entregado el 04 jul 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 01 jul 1997 Entregado el 03 jul 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 12 dic 1994 Entregado el 28 dic 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CB (1994) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0