MOBIUS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MOBIUS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC330383 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MOBIUS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra MOBIUS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Fourth Floor 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MOBIUS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INFINIS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED | 03 may 2011 | 03 may 2011 |
| SSE RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED | 23 dic 2009 | 23 dic 2009 |
| AIRTRICITY GENERATION (GB) LIMITED | 05 sept 2007 | 05 sept 2007 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MOBIUS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MOBIUS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 24 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MOBIUS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2024 | 15 páginas | AA | ||
legacy | 101 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Cese del nombramiento de Ian James Urquhart como director el 28 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2023 | 15 páginas | AA | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 59 páginas | PARENT_ACC | ||
Nombramiento de Ms Emily Rose Sale como director el 13 jun 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Rui Jorge Maia Da Silva como director el 13 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Ian James Urquhart como director el 06 jun 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr John David Mills como director el 06 jun 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Pablo Andres como director el 06 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Burness Paull Llp como secretario el 10 jun 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ Scotland a Fourth Floor 12 Blenheim Place Edinburgh EH7 5JH el 04 jun 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cessation de Ranelagh Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 dic 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cancelación total de la carga SC3303830008 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga SC3303830007 | 1 páginas | MR04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2022 | 13 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de MOBIUS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLS, John David | Director | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh Fourth Floor Scotland | Scotland | British | 162153070003 | |||||||||||||
| SALE, Emily Rose | Director | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh Fourth Floor Scotland | England | British | 312786440001 | |||||||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secretario | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201245540001 | |||||||||||||||
| BISSET, Graham Ferguson | Secretario | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194566510001 | |||||||||||||||
| CALDER, Samantha Jane | Secretario | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | British | 75830790003 | ||||||||||||||
| DONNELLY, Lawrence John Vincent | Secretario | Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House 200 Perthshire | British | 129227760001 | ||||||||||||||
| LONG, Jacqueline | Secretario | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204213320001 | |||||||||||||||
| BURNESS PAULL LLP | Secretario corporativo | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland |
| 274632510001 | ||||||||||||||
| HMS SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | The Ca'D'Oro 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow | 900004320001 | |||||||||||||||
| MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 2 Lister Square Quartermile Two EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Scotland |
| 95512800001 | ||||||||||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Director | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | England | British | 294355310001 | |||||||||||||
| ALEXANDER, Fraser Mcgregor | Director | 200 Dunkeld Rd PH1 3AN Perth Inveralmond House Perthshire | United Kingdom | British | 65278040002 | |||||||||||||
| ANDRES, Pablo | Director | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh 4th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 276031210001 | |||||||||||||
| BOYD, Gordon Alexander | Director | 50 Frederick Street EH2 1EX Edinburgh First Floor Scotland Scotland | England | British | 148856600001 | |||||||||||||
| BROWN, Katerina | Director | 5th Floor, Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh C/O Morton Fraser Llp | Scotland | British | 232165890001 | |||||||||||||
| DONALDSON, Peter Symons | Director | PH16 5NF Pitlochry Clunie Power Station Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131456210001 | |||||||||||||
| DOWLING, Paul Cyril | Director | Weston Carrick Brook, Eadestown Naas County Kildare Ireland | Ireland | Irish | 111811130002 | |||||||||||||
| FITZGERALD, Louis Francis | Director | Dunany 32 Stillergan Grove IRISH Blackrock County Dublin Ireland | Ireland | Irish | 147380310001 | |||||||||||||
| FLYNN, Donal Francis | Director | 3 Whitebeam Avenue Clonskeagh IRISH Dublin 14 Ireland | Ireland | Irish | 126967800001 | |||||||||||||
| GIBBINS, Stewart Charles | Director | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | United Kingdom | British | 148918290002 | |||||||||||||
| GIBLIN, Caoimhe Mary | Director | Airtricity House Ravenscourt Office Park Sandyford Dublin 18 | Ireland | Irish | 153538670001 | |||||||||||||
| GREGSON, Paul Jonathan | Director | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | England | British | 154908310001 | |||||||||||||
| GRIFFITHS, David Huw | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | United Kingdom | British | 177733400003 | |||||||||||||
| GUERIN, Daniel Joseph | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | England | Irish | 210311660001 | |||||||||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Director | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | Uk | British | 93743250007 | |||||||||||||
| HINTON, Thomas Edward | Director | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 238940970001 | |||||||||||||
| JONES, Mark Richard | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | United Kingdom | British | 264835170001 | |||||||||||||
| LEE, Andrew William | Director | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp United Kingdom | United Kingdom | British | 87527870001 | |||||||||||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne | Director | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | England | Belgian | 125748990002 | |||||||||||||
| MACKENZIE, Scott Leitch | Director | 5th Floor, Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 277478140001 | |||||||||||||
| MURPHY, Senan | Director | 2 Cranford Terenure Road West IRISH Dublin 6w Ireland | Irish | 95157200001 | ||||||||||||||
| NAGLE, Michael | Director | 5th Floor, Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 29436380007 | |||||||||||||
| O'CONNOR, Edward | Director | The Palms Roebuck Road Dublin 52 14 Ireland | Ireland | Irish | 136827730001 | |||||||||||||
| PICKERING, Stephen Shane | Director | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 198076630001 | |||||||||||||
| SILVA, Rui Jorge Maia Da | Director | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | Portugal | Portuguese | 286966010001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MOBIUS RENEWABLES GENERATION (GB) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobius Wind Holdings Limited | 15 ago 2019 | St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mobius Wind Holdings Limited | 15 ago 2019 | 133-137 Alexandra Road Wimbledon SW19 7JY London Connect House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Ranelagh Nominees Limited | 21 dic 2017 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Jupiter Acquisitions Limited | 21 dic 2017 | 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martin's House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Natwest Fis Nominees Limited | 06 abr 2016 | Devonshire Square COUTTS & C EC2M 4BA London 2 1/2 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0