• Datos
  • Gran Bretaña
  • Empresas
  • Buscar empresas
  • Sanciones
  • Buscar sanciones
  • Jonah PERELMAN - Página 2

    Persona Física

    TítuloMr
    NombreJonah
    ApellidoPERELMAN
    Fecha de Nacimiento
    ¿Es Ejecutivo Corporativo?No
    Nombramientos
    Activo54
    Inactivo6
    Renunciado11
    Total71

    Nombramientos

    Cargos Designados
    Designado enFecha de DesignaciónFecha de RenunciaEstado de la EmpresaOcupaciónRolDirecciónPaís de ResidenciaNacionalidad
    PEARLQUEST LTD03 jun 2019ActivaDirector
    Linthorpe Road
    N16 5QT London
    43
    England
    EnglandBritish
    THORPEBEAM ESTATES LTD08 dic 2017DisueltaDirector
    Craven Park Road
    South Tottenham
    N15 6AB London
    50
    England
    EnglandBritish
    NEWEST PROPERTIES LTD06 may 2017ActivaDirector
    Craven Walk
    Suite #2
    N16 6BT London
    10
    England
    EnglandBritish
    NEWBAY PROPERTIES LIMITED20 ene 2016ActivaDirector
    N16 5QT London
    43 Linthorpe Road
    United Kingdom
    EnglandBritish
    PEREL INVESTMENTS LTD02 dic 2013ActivaDirector
    Leweston Place
    Leweston Place
    N16 6RJ London
    39
    England
    EnglandBritish
    BP PROPERTY INVESTMENT LIMITED02 ago 2013DisueltaDirector
    Linthorpe Rd
    N16 5QT London
    43
    England
    EnglandBritish
    AJ PROPERTY LIMITED24 jun 2013DisueltaDirector
    Leweston Place
    N16 6RJ London
    39
    United Kingdom
    EnglandBritish
    PEG ESTATES LTD12 abr 2010ActivaDirector
    Linthorpe Road
    N16 5QT London
    43
    England
    EnglandBritish
    PALMHILL ESTATES LTD21 dic 2006ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    DINA PERELMAN TRUST LIMITED07 feb 2006ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    GEMWAY ESTATES LTD01 may 2004ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    ARCHGATE ESTATES LTD31 mar 2003ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    EURO TWO ESTATES LTD09 dic 2002ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    EURO THREE ESTATES LTD09 dic 2002DisueltaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    FIRSTQUEST LTD12 sept 2002ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    TOLLSHUNT LIMITED27 may 2002ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    WHITEHALL GALLERY LTD28 feb 2002ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    EAGLEVIEW ESTATES LTD15 jul 2001ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    NEWFIELD ESTATES LTD07 jul 2001ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    CRESTPATH ESTATES LTD01 abr 2001ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    FINEPATH LTD21 jul 1998ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    TARGETWAY LTD08 jul 1998ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    REGALMARK PROPERTIES LIMITED06 may 1998ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    CITYMARK PROPERTIES LTD22 ene 1998DisueltaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    COLTSTATE LIMITED19 ago 1997ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    FRT REAL ESTATE LTD24 nov 202427 ene 2025ActivaDirector
    Lewis Gardens
    N16 5PF London
    5
    England
    EnglandBritish
    CHERRY CLOSE LTD22 nov 202228 jun 2023ActivaDirector
    Northfield Road
    N16 5FB London
    4 Shushan Close
    England
    EnglandBritish
    EURO ONE ESTATES LTD22 mar 200227 jul 2022ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    PERELBOK LIMITED11 may 201711 may 2022ActivaDirector
    26 Theydon Road
    E5 9NA London
    Js & Co Accountants
    England
    EnglandBritish
    ALDZ INVESTMENTS LTD20 may 202117 jun 2021ActivaDirector
    High Road
    N15 6LS London
    10
    England
    EnglandBritish
    KENIG LIMITED24 may 201820 may 2021ActivaDirector
    Denver Road
    N16 5JH London
    26c
    England
    EnglandBritish
    HILLVIEW ESTATES LTD03 abr 200020 may 2021ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    SMART ESTATES LIMITED28 nov 200711 dic 2014ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    ACESTAR PROPERTIES LTD03 abr 200023 mar 2004ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish
    ARCHGATE ESTATES LTD22 jul 200102 may 2003ActivaDirector
    43 Linthorpe Road
    N16 5QT London
    EnglandBritish

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0